TWEED PREMIER 1 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTWEED PREMIER 1 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02847978
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TWEED PREMIER 1 LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich TWEED PREMIER 1 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TWEED PREMIER 1 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ADVANCESAVE PUBLIC LIMITED COMPANY25. Aug. 199325. Aug. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TWEED PREMIER 1 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für TWEED PREMIER 1 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 14. Aug. 2017

    • Kapital: GBP 5.000004
    3 SeitenSH19

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    legacy

    1 SeitenSH20

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    3 SeitenAA

    Ernennung von Mr Charles John Middleton als Direktor am 23. März 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Jonathan Charles Mcnuff als Direktor am 23. März 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Michael John Forshaw als Geschäftsführer am 13. März 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ndiana Ekpo als Sekretär am 06. Dez. 2016

    1 SeitenTM02

    Ernennung von British Land Company Secretarial Limited als Sekretär am 06. Dez. 2016

    2 SeitenAP04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 25. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 2,500,002
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 25. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 2,500,002
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 2,500,002
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Michael John Forshaw am 27. Aug. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Jones als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von TWEED PREMIER 1 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer8992198
    187856670001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Sekretär
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Sekretär
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Sekretär
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    CHILDS, Lisbeth Ann, Doctor
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    Sekretär
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    British50515040002
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    DOWDESWELL, Jacqueline Anne
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Sekretär
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    British50592080001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    GULHANE, Angeli Asha
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    Sekretär
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    British38173040001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    British106162380001
    MACRAE, Alistair Ian
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    British71950710001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Sekretär
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    THE BRITISH LINEN BANK LIMITED
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    41450001
    BALLINGALL, Stuart James
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British57693580001
    BAMBER, Roger Stanley
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish2419370002
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Geschäftsführer
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    British18955940002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Geschäftsführer
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Geschäftsführer
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Geschäftsführer
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    United KingdomBritish59208430002
    CASSELS, Alexander
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British566790001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COLLINS, Roger
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    British45885520003
    CRUICKSHANK, James Kerr
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    British46894940001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Geschäftsführer
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish1898090001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Geschäftsführer
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish106162380001
    HUNTER, John Stewart
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    Geschäftsführer
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    ScotlandBritish1127070001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Geschäftsführer
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Geschäftsführer
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MURRAY, Edward Davidson
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish504780001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TWEED PREMIER 1 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Cornish Residential Property Investments Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06. Apr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Compay Limited By Shares
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat TWEED PREMIER 1 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2003
    Geliefert am 30. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    60 cornwallis avenue, worle, weston super mare, avon t/n AV73005, 34 borough road, dunstable, beds t/n BD125734, 8 strawplait way, arlesey, beds t/n BD145597 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Flat 71 harbour street nairn t/no NRN193 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    79 candleriggs glasgow t/no GLA5367, 4 sandbank street glasgow t/no GLA28163, ardgowan court 11 gray street glasgow t/no GLA104540 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    7 ivybank court polmont t/no STG24701, 8 ivybank court polmont t/no STG24729, 11 buchanan court falkirk t/no STG13643. For details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 islay crescent old kilpatrick t/no DMB46579, 14 craigash road milngavie t/no DMD32993, 54 lime crescent cumbernauld t/no DMD19975 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Northwest most first floor flat 13B alexandra street kirkcaldy t/no FFE57703, 77 burnside auchtermuchty fife t/no FFE57801, 99 st michaels drive cupar fife t/no FFE57699 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    8 blackfriars mews blackfriars wynd perth t/no PTH15500, ground floor flat 1 station road dunning perth t/no PTH15414, second floor attic flat 5 station road dunning perth t/no PTH15416 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    0/1, 3 clavering street east paisley t/no REN66468, 8 tarras drive renfrew t/no REN13753 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    9 burnside court diriebught road inverness t/no UNV1681, 11 burnside court diriebught road inverness t/no INV1680, 15 burnside court diriebught road inverness T.no INV1679 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    26 ledi avenue tullibody t/no CLK1634 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    26 fowler terrace edinburgh t/no MID30588, 1/7 southhouse square edinburgh t/no MID30943, 10 west werberside edinburgh t/no MID30590 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    30 rhindmuir drive baillieston glasgow t/no LAN84451, 32 armstrong crescent uddingston glasgow t/no LAN119926, 58 calderwood road rutherglen glasgow t/no LAN99971 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    13A portland street troon t/no AYR47650, 18 glenlyon grove stanecastle village irvine t/no AYR47648, 1 beresford grove stanecastle village irvine t/no AYR47647 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee and the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) 5 haldon grove,northfield B31 4LN; WK209571; (ii) 90 hargate lane,west bromwich; WM11484; (iii) 61 pleckgate rd,blackburn BB1 8PN; la 35114; see form 395 for details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society,as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    0/1 3 clarering street east paisley PA1 2PU title number REN66468. 8 tarras drive renfrew PA4 0YZ title number REN13753.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    27 bank street aloa FK10 1HP title number CLK728. 26 ledi avenue tullibody FK10 2RZ title number CLK1634.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Northwestmost first floor flat 13B alexandra street kirkcaldy KY1 1HG title number FFE57703. 77 burnside auchtermuchty fife KY14 7AL title number FFE57801. 99 st mikchaels drive cupar fife KY15 5BP title number FFE57699. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 ivybank court polmont FK2 0GH title number STG24726. 17 ivybank court polmont FK2 0GH title number STG24728. 2 ivybank court polmont FK2 0GH title number STG24725. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    79 candleriggs glasgow title number GLA5367. 4 sandbank street glasgow G20 0PJ title number GLA28163. Ardgowan court 11 gray street glasgow G3 7TX title number GLA104540. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Flat 71 harbour street nairn title number NRN193.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    30 rhindmuir drive baillieston glasgow G69 6ND title number LAN84451. 32 armstrong crescent uddingston glasgow G71 6TF title number LAN119926. 58 calderwood road rutherglen glasgow G73 3HE title number LAN99971. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    13A portland street troon title number AYR47650. 18 glenlyon grove stanecastle village irvine KA11 1RW title number AYR47648. 1 beresford grove stanecastle village irvine KA11 1RW title number AYR47647. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    11 burnside court diriebught road inverness title number INV1680. 15 burnside court diriebught road inverness title number INV1679. 17 burnside court diriebught road inverness title number INV1678. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    8 blackfriars mews blackfriars wynd perth PH1 5LR title number PTH15500. Ground floor flat 1 station road dunning perth PH2 0RH title number PTH15414. Second floor attic flat 5 station road dunning perth PH2 0RH title number PTH15416. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0