TWEED PREMIER 3 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TWEED PREMIER 3 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02847988 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TWEED PREMIER 3 LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich TWEED PREMIER 3 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TWEED PREMIER 3 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FUTURECOIN PUBLIC LIMITED COMPANY | 25. Aug. 1993 | 25. Aug. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TWEED PREMIER 3 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TWEED PREMIER 3 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Jones als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Apr. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Roberts als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Webb als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Taylor als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lucinda Bell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Clarke als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sarah Barzycki als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ndiana Ekpo am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TWEED PREMIER 3 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKPO, Ndiana | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Geschäftsführer | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||
| BLACK, Lysanne Jane Warren | Sekretär | 6 Belgrave Crescent EH4 3AQ Edinburgh | British | 46707740002 | ||||||
| BOND, Richard Keith | Sekretär | 9 Cranford Brooklea Park Lisvane CF14 0XE Cardiff | British | 59208430002 | ||||||
| BOND, Richard Keith | Sekretär | 9 Cranford Brooklea Park Lisvane CF14 0XE Cardiff | British | 59208430002 | ||||||
| CHILDS, Lisbeth Ann, Doctor | Sekretär | 17 Gay Street BA1 2PH Bath Avon | British | 50515040002 | ||||||
| DIMENT, Peter Charles Michael | Sekretär | 4 Westfield Close CM23 2RD Bishops Stortford Hertfordshire | British | 32770400001 | ||||||
| DOWDESWELL, Jacqueline Anne | Sekretär | 54 Lower Westwood BA15 2AE Bradford On Avon Wiltshire | British | 50592080001 | ||||||
| GULHANE, Angeli Asha | Sekretär | Flat 4 3 Lansdown Crescent BA1 5EX Bath Avon | British | 38173040001 | ||||||
| HODGE, Robert John | Sekretär | Nant Fawr Graig Road Lisvane CF14 0UF Cardiff South Glamorgan | British | 106162380001 | ||||||
| MACRAE, Alistair Ian | Sekretär | 32 The Steils EH10 5XD Edinburgh Midlothian | British | 71950710001 | ||||||
| SAUNDERS, Timothy, Mr. | Sekretär | Beckets Place Marksbury BA2 9HP Bath Avon | British | 47952140001 | ||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Sekretär | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| THE BRITISH LINEN BANK LIMITED | Sekretär | 4 Melville Street EH3 7NZ Edinburgh Midlothian | 41450001 | |||||||
| BALLINGALL, Stuart James | Geschäftsführer | 78/10 Orchard Brae Avenue EH4 2GA Edinburgh Midlothian Scotland | British | 57693580001 | ||||||
| BAMBER, Roger Stanley | Geschäftsführer | Whithorne Coach House London Road Charlton Kings GL52 6UY Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 2419370002 | |||||
| BARKLEY, John | Geschäftsführer | 10 Willow Tree Place The Beeches EH14 5AZ Balerno Edinburgh, Midlothian | British | 18955940002 | ||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Geschäftsführer | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||
| BELL, Lucinda Margaret | Geschäftsführer | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||
| BOND, Richard Keith | Geschäftsführer | 9 Cranford Brooklea Park Lisvane CF14 0XE Cardiff | United Kingdom | British | 59208430002 | |||||
| CASSELS, Alexander | Geschäftsführer | 634 Queensferry Road EH4 6DZ Edinburgh Midlothian | British | 566790001 | ||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Geschäftsführer | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||
| COLLINS, Roger | Geschäftsführer | 3 Hann Close BA5 2JR Wells Somerset | British | 45885520003 | ||||||
| CRUICKSHANK, James Kerr | Geschäftsführer | 3 Mid Steil Glenlockhart EH10 5XB Edinburgh Midlothian | British | 46894940001 | ||||||
| GUNSTON, Michael Ian | Geschäftsführer | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||
| HALLAM, Jonathan Paul | Geschäftsführer | 11 Trinity Road SW19 8QT London | British | 36631180001 | ||||||
| HODGE, Robert John | Geschäftsführer | Nant Fawr Graig Road Lisvane CF14 0UF Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 106162380001 | |||||
| HUNTER, John Stewart | Geschäftsführer | 27 Queens Crescent EH9 2BA Edinburgh | Scotland | British | 1127070001 | |||||
| JONES, Andrew Marc | Geschäftsführer | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||
| METLISS, Cyril | Geschäftsführer | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||
| MURRAY, Edward Davidson | Geschäftsführer | 27 Barnshot Road EH13 0DJ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 504780001 | |||||
| ONEIL, James Charles | Geschäftsführer | 12 Antigua Street EH1 3NH Edinburgh | British | 63521290001 | ||||||
| RADLEY, Alan John | Geschäftsführer | 35 Beaconsfield Way BA11 2UD Frome Somerset | British | 80260530001 | ||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Geschäftsführer | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | 63986410003 |
Hat TWEED PREMIER 3 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 30. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 26 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108953, 16 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108956, 24 beck riggs, longtown road, brampton, cumbria t/n CU108960 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 23. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 195 mains drive erskine t/no REN27597 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 23. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 12 the oaks killearn t/no STG10016 all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee and the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (I) plot 2,beck riggs,brampton CU108956; (ii) flat 1,23 lansdowne rd,purley; SGL577213; (iii) 51 azalea close,ilford; EGL335123; see form 395 for details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and | Erstellt am 30. Dez. 2002 Geliefert am 04. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 195 mains drive erskine PA8 7JN title number REN27597. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and | Erstellt am 30. Dez. 2002 Geliefert am 04. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 12 the oaks killearn title number STG10016. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0