SYG REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSYG REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02850053
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SYG REALISATIONS LIMITED?

    • (3511) /

    Wo befindet sich SYG REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Vantage Point Woodwater Park
    Pynes Hill
    EX2 5FD Exeter
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SYG REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE SELECT YACHT GROUP LIMITED27. Mai 200327. Mai 2003
    CORNISH CRABBERS HOLDINGS LIMITED29. Okt. 199329. Okt. 1993
    TALCROFT LIMITED02. Sept. 199302. Sept. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SYG REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für SYG REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Okt. 2012

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Nov. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Nov. 2009

    5 Seiten4.68

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed the select yacht group LIMITED\certificate issued on 23/02/09
    3 SeitenCERTNM

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    10 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Nov. 2008

    LRESEX

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    25 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten88(2)R

    legacy

    2 Seiten88(2)R

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von SYG REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COLAM, Christian
    28 The Heathers
    PL6 7QT Plymouth
    Devon
    Sekretär
    28 The Heathers
    PL6 7QT Plymouth
    Devon
    British109985240001
    COLAM, Frank Frederick
    The Woodshed
    Pityme, Rock
    PL27 6NT Wadebridge
    Cornwall
    Geschäftsführer
    The Woodshed
    Pityme, Rock
    PL27 6NT Wadebridge
    Cornwall
    British49168500007
    COLAM, Clara
    Mere Court Road
    PL8 1BZ Newton Ferrers
    Devon
    Sekretär
    Mere Court Road
    PL8 1BZ Newton Ferrers
    Devon
    British58625210001
    COLAM, Frank Frederick
    Mill Cottage 34 Walkhampton Road
    Horrabridge
    PL20 7SZ Yelverton
    Devon
    Sekretär
    Mill Cottage 34 Walkhampton Road
    Horrabridge
    PL20 7SZ Yelverton
    Devon
    British49168500001
    COLAM, Karen
    Rialton Barton Mill
    TR8 4JP St Columb Minor
    Cornwall
    Sekretär
    Rialton Barton Mill
    TR8 4JP St Columb Minor
    Cornwall
    British80731740001
    HARGREAVES, Gary John
    2 Glebe Crescent
    St Issey
    PL27 7HJ Wadebridge
    Cornwall
    Sekretär
    2 Glebe Crescent
    St Issey
    PL27 7HJ Wadebridge
    Cornwall
    British21883580002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    COLAM, Alie Elise
    Mill Cottage 34 Walkhampton Road
    Horrabridge
    PL20 7SZ Yelverton
    Devon
    Geschäftsführer
    Mill Cottage 34 Walkhampton Road
    Horrabridge
    PL20 7SZ Yelverton
    Devon
    Dutch49168880001
    HARGREAVES, Gary John
    2 Glebe Crescent
    St Issey
    PL27 7HJ Wadebridge
    Cornwall
    Geschäftsführer
    2 Glebe Crescent
    St Issey
    PL27 7HJ Wadebridge
    Cornwall
    British21883580002
    HARGREAVES, Jillian
    2 Glebe Crescent
    PL27 7HJ St. Issey
    Cornwall
    Geschäftsführer
    2 Glebe Crescent
    PL27 7HJ St. Issey
    Cornwall
    British91689100001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat SYG REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 30. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Finance Cornwall Business Fund Limited
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Dez. 2005
    Geliefert am 13. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land and buildings south side of pityme farm rock st minver. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment of keyman life policy intimation dated 07/12/2005 and
    Erstellt am 07. Dez. 2005
    Geliefert am 13. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Scottish equitable PLC policy number L0196904862 dated 14/10/2005 for the sum of £250000 life assured frank frederick colam together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 2005
    Geliefert am 03. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Mystery 35 and assigns all the freights hire passage moneys requisition compensation salvage or towage remuneration demurrage detention moneys and other moneys whatsoever earned by the vessel.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Juli 2005
    Geliefert am 26. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Marine mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 01. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Landau 29 hin number GB-BIHLC003K404 all freights hire passage moneys requisition compensation salvage or towage remuneration demurrage detention moneys and other moneys earned by the vessel.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Marine mortgage (to secure account current)
    Erstellt am 08. Dez. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Landau 20 hin no GB-HUNLC001L203 with all freights hire passage moneys requisition compensation and other moneys thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 12. Nov. 2004
    Geliefert am 13. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cornish diva 36 hin number GB- BIH36003B404. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Marine mortgage
    Erstellt am 18. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cornish diva 36 hin number GB-BIH36003B404 all freights hire passage moneys requisition compensation salvage or towage remuneration demurrage detention moneys and other moneys whatsoever to be earned by the vessel.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Marine mortgage
    Erstellt am 18. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Landau 29 hin number GB-HUNLC002J303 mortgagor hereby assigns to the bank first all the freights hire passage moneys requisition compensation salvage or towage remuneration demurrage detention moneys and other moneys whatsoever to be earned by the vessel.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Aug. 1996
    Geliefert am 22. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land at pityme industrial estate rock wadebridge cornwall floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Johannus Jacobus Colam
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Nov. 1993
    Geliefert am 02. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Nov. 1993
    Geliefert am 01. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-pityme industrial estate rock wadebridge cornwall and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SYG REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Jan. 2013Aufgelöst am
    07. Nov. 2008Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen James Hobson
    Vantage Point Woodwater Park
    Pynes Hill
    EX2 5FD Exeter
    Praktiker
    Vantage Point Woodwater Park
    Pynes Hill
    EX2 5FD Exeter

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0