FERRO MONK SYSTEMS LTD
Überblick
Unternehmensname | FERRO MONK SYSTEMS LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02850619 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FERRO MONK SYSTEMS LTD?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FERRO MONK SYSTEMS LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FERRO MONK SYSTEMS LTD?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HALLGARTH CONSTRUCTION LIMITED | 26. Okt. 1993 | 26. Okt. 1993 |
STREETBUSY ENTERPRISES LIMITED | 06. Sept. 1993 | 06. Sept. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FERRO MONK SYSTEMS LTD?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FERRO MONK SYSTEMS LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Sept. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert John Vickers als Geschäftsführer am 28. Juni 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Jan. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert John Vickers als Direktor am 06. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Pattison am 28. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Frederick Martin als Geschäftsführer am 31. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Pattison als Direktor am 29. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Pattison als Sekretär am 29. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Howard Bales als Geschäftsführer am 29. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Howard Bales als Sekretär am 29. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kay Jenna Cusworth als Geschäftsführer am 29. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FERRO MONK SYSTEMS LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATTISON, Ian | Sekretär | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | 208124570001 | |||||||
PATTISON, Ian | Geschäftsführer | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | United Kingdom | British | Finance Director | 160032140003 | ||||
RADCLIFFE, Stephen John | Geschäftsführer | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 80781440002 | ||||
BALES, Michael Howard | Sekretär | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | British | Finance Director | 2645510001 | |||||
BOWEN, Patricia Margaret, Mrs. | Sekretär | 2 Northernhay DT1 1XN Dorchester Dorset | British | 127444930001 | ||||||
FARRELL, Susan Mary | Sekretär | 12 Brookfield Avenue Glasshoughton WF10 4BJ Castleford West Yorkshire | British | 18799920001 | ||||||
HOLMES, Ian | Sekretär | 34 Hillcrest Drive Brighouse Road Queensbury BD13 2QT Bradford West Yorkshire | British | Company Secretary | 44142390001 | |||||
VENN, Andrew Michael | Sekretär | 46 Woodhill View LS22 6PP Wetherby West Yorkshire | British | 64471090001 | ||||||
WILKINSON, John Barry | Sekretär | Avondale 5 Norwood Close Off Boroughbridge Road HG5 0NN Knaresborough North Yorkshire | British | 36549210001 | ||||||
WILSON, Alan | Sekretär | 20 Westfield Park Elloughton HU15 1AN Brough East Yorkshire | British | Group Financial Controller | 147755040001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ADAMS, David | Geschäftsführer | 3 Hallgarth Villas Sherburn Village DH6 1HA Durham | England | British | Company Director | 53919860001 | ||||
BALES, Michael Howard | Geschäftsführer | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | United Kingdom | British | Finance Director | 2645510001 | ||||
BURNETT, John Martin | Geschäftsführer | Millwood House Blackthorn Lane Cammeringham LN1 2SH Lincoln | England | British | Company Director | 70646680001 | ||||
BUTCHER, Roy | Geschäftsführer | St Andrew's House Castle Howard Road YO17 7AY Malton N Yorkshire | England | British | Group Chief Executive | 364670031 | ||||
CLUGSTON, John Westland Antony | Geschäftsführer | The Old Vicarage Scawby DN20 9LX Brigg North Lincolnshire | England | British | Chairman | 2292210001 | ||||
CUSWORTH, Kay Jenna | Geschäftsführer | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | England | British | Finance Director | 111600660001 | ||||
HEFFERNAN, Daniel Edward | Geschäftsführer | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | England | British | Divisional Director | 84435960001 | ||||
HEFFERNAN, Daniel Edward | Geschäftsführer | 107 Heythrop Drive Acklam TS5 8QJ Middlesbrough Cleveland | British | Civil Engineer | 60934120001 | |||||
MARTIN, Stephen Frederick | Geschäftsführer | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | England | British | Director | 117868520002 | ||||
TANKARD, Roger Piers | Geschäftsführer | 24 St Anns Road CW10 9HJ Middlewich Cheshire | United Kingdom | British | Divisional Director | 37699540001 | ||||
TANKARD, Roger Piers | Geschäftsführer | 24 St Anns Road CW10 9HJ Middlewich Cheshire | United Kingdom | British | Civil Engineer | 37699540001 | ||||
TILLEY, Stewart Arthur | Geschäftsführer | Knaith Park DN21 5HB Gainsborough Stephensons Hill House South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 123096270003 | ||||
TUDOR, Patrick | Geschäftsführer | The Hall 32 Northumberland Street NE66 2RA Alnmouth Northumberland | England | British | Education Advisor | 90832970001 | ||||
VENN, Andrew Michael | Geschäftsführer | 12 Manley Drive LS22 6XQ Wetherby West Yorkshire | British | Director | 64471090003 | |||||
VENN, Andrew Michael | Geschäftsführer | 46 Woodhill View LS22 6PP Wetherby West Yorkshire | British | Factory Manager | 64471090001 | |||||
VENN, Anthony Bryan | Geschäftsführer | 2 Deerstone Ridge LS22 7XN Wetherby West Yorkshire | British | Company Director | 36549300002 | |||||
VICKERS, Robert John | Geschäftsführer | Saint Vincent House Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe North Lincolnshire | England | British | Chief Executive Officer | 164124450001 | ||||
WILSON, Alan | Geschäftsführer | 20 Westfield Park Elloughton HU15 1AN Brough East Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 147755040001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FERRO MONK SYSTEMS LTD?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clugston Group Limited | 06. Apr. 2016 | Normanby Road DN15 8QT Scunthorpe St Vincent House North Lincolnshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat FERRO MONK SYSTEMS LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 06. Jan. 2006 Geliefert am 18. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security document | Erstellt am 03. Mai 2001 Geliefert am 10. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any finance party on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 03. Nov. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Various plant and equipment located at ferro monk systems LTD south milford leeds LS25 5LH and on site at shaw road oldham as at 30TH july 1997 and all monies recieved on any insurance whatsoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1995 Geliefert am 07. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings situate pointer farm, great north road, south milford, north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Jan. 1995 Geliefert am 23. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 18. Mai 1994 Geliefert am 23. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0