GEPP REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGEPP REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02854560
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GEPP REALISATIONS LIMITED?

    • (2416) /

    Wo befindet sich GEPP REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GEPP REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GLOBAL ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS LIMITED30. Aug. 200730. Aug. 2007
    NYLACAST MATERIALS LIMITED08. Jan. 200708. Jan. 2007
    NYLACAST LIMITED17. Sept. 199317. Sept. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GEPP REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für GEPP REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    SeitenCOCOMP

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order replacement liquidators 30/11/2010.
    20 SeitenLIQ MISC OC

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    COCOMP

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    7 SeitenCOCOMP

    Beendigung der Bestellung von Simon Gilbert als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Nov. 2009

    55 Seiten2.24B

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    1 Seiten2.33B

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    1 Seiten2.33B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Nov. 2009

    55 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Mai 2009

    9 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Nov. 2008

    9 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    2 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    21 SeitenMEM/ARTS

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed global engineering plastic products LIMITED\certificate issued on 18/08/08
    4 SeitenCERTNM

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Nov. 2008

    9 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    5 Seiten2.23B

    Wer sind die Geschäftsführer von GEPP REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FRASER, Maximillian Harry
    The Manor House
    2 Norton Lane
    LE7 9BU Gaulby
    Leicestershire
    Sekretär
    The Manor House
    2 Norton Lane
    LE7 9BU Gaulby
    Leicestershire
    British43994990004
    FRASER, Maximillian Harry
    The Manor House
    2 Norton Lane
    LE7 9BU Gaulby
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    2 Norton Lane
    LE7 9BU Gaulby
    Leicestershire
    British43994990004
    FRASER, Phineas Rupert
    Smithy Farmhouse
    2 Back Lane
    LE7 9LP Gaulby
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Smithy Farmhouse
    2 Back Lane
    LE7 9LP Gaulby
    Leicestershire
    British100114580001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    FRASER, Anita Cherry
    54 Saint Leonards Street
    PE9 2HN Stamford
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    54 Saint Leonards Street
    PE9 2HN Stamford
    Lincolnshire
    British10597410004
    FRASER, Michael
    Pond House 437 Uppingham Road
    LE5 6RA Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Pond House 437 Uppingham Road
    LE5 6RA Leicester
    Leicestershire
    British5607940001
    GILBERT, Simon
    Owl Corner
    Whissendine Road, Ashwell
    LE15 7LT Oakham
    Rutland
    Geschäftsführer
    Owl Corner
    Whissendine Road, Ashwell
    LE15 7LT Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish34372250003
    MOHAMED, Mussa
    437 Uppingham Road
    LE5 6RA Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    437 Uppingham Road
    LE5 6RA Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish118172730001
    RANDALL, James
    Cawthorn Marefield Lane
    Burrough On The Hill
    LE14 2QX Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Cawthorn Marefield Lane
    Burrough On The Hill
    LE14 2QX Melton Mowbray
    Leicestershire
    British12680470003
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat GEPP REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2007
    Geliefert am 10. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over deposit
    Erstellt am 05. Jan. 2007
    Geliefert am 11. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its entire right, title and interest in and to all money in any currency standing to the credit of the account with the bank at 14 friar lane, leicester, account number 06028381. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 27. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £218,320.03 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    Rotoplanes 53T serial nos 3596 and 3597 together with all accessories and component parts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment and tooling :- melt processing unit, 2 x melt tanks (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Trw Lucasvarity Electric Steering Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 24. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All sums assured under the policy of insurance policy number 8209499EW.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property on the south side of portishead road leicester t/n LT7792. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property on the north west and west sides of victoria road east leicester t/n LT2428. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property on the north east side of withcote avenue leicester t/n LT165089. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 3A brighton road leicester t/n LT56398. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 5 brighton road leicester t/n LT9236. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 3 brighton road leicester t/n LT4307. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 2002
    Geliefert am 22. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 21. Aug. 2002
    Geliefert am 24. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £140,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    One automated melt processing unit mpu-500(pc) s/n NYLNT02152 and all parts accessories etc.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 23. Juli 2002
    Geliefert am 24. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The proceeds of all policies of insurance now or in the future taken out by the company in respect of the equipment and the benefit of all options and rights devolving the company under any such policy of insurance. 1996 colchester tornado 300 2 axis cnc lathe C30241, 1996 colchester tornado 300 2 axis cnc lathe C30196, 1997 bridgeport vmc 800/22 vertical machining centre cc/w pheonix manual pallet change system 720366, for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Industrial Equipment Finance Limited
    Transaktionen
    • 24. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 08. Juli 2002
    Geliefert am 17. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company as owner with full title guarantee hereby assigns unto the lender all and singular the goods by way of security for the payment to the lender of all monies hereby covenanted to be paid, (self built) automatic melt processing unit, model: mpu-500 pc s/n NYLNT02119.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Marine mortgage recorded in the register of british ships on 19TH february 2002
    Erstellt am 18. Feb. 2002
    Geliefert am 22. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current
    Kurze Angaben
    64/64 shares in the ship princess 45 "new jade" hull id no: GBMPPR6055E101 official number: 904804 and in its appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 09. Juli 2001
    Geliefert am 17. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the agreement or this mortgage
    Kurze Angaben
    1-Alpha romeo 8C spider corsa - chassis no 2111026,engine no R000105 and any spares or accessories thereto; the proceeds of sale thereof and any insurance policies and the proceeds of any claim thereunder; any maintenance contracts of such goods,guarantees,manual,licences,certificates,records and other documents thereto.
    Berechtigte Personen
    • Associates Commercial Corporation LTD
    Transaktionen
    • 17. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Marine mortgage
    Erstellt am 06. Juli 2001
    Geliefert am 11. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £250,000.00 together with all sums due or to become due from the company to the chargee by way of principal or interest
    Kurze Angaben
    Vessel k/a princess 45 hull id no GBMPPR6055E101.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2001
    Geliefert am 31. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £140,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Automated melt processing unit mpu-500 (pc) including additional melt dispensing accuracy modification (serial number NYLNT01017) together with accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books, manuals, handbooks,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 26. Jan. 2001
    Geliefert am 01. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Nylacast oven-SC03 s/no s chamber s/no NYL2000063, nylacast oven-SC02 chamber s/no NYL2000064, nylacast plate unit ppu-104 proc unit s/no NYL2000021.for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Sept. 2000
    Geliefert am 05. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 5 brighton road leicester t/n LT9236. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Sept. 2000
    Geliefert am 05. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 3A brighton road leicester t/n LT56398. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Sept. 2000
    Geliefert am 05. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 3 brighton road leicester t/no: LT4307. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Sept. 2000
    Geliefert am 05. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land on the north east side of withcote avenue leicester t/n LT165089. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GEPP REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Nov. 2007Beginn der Verwaltung
    23. Nov. 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stuart David Maddison
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castel Donnington East Midlands
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castel Donnington East Midlands
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Colin Michael Trevethyn Haig
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    2
    DatumTyp
    04. Nov. 2009Antragsdatum
    13. Nov. 2009Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Matthew Hammond
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Colin Michael Trevethyn Haig
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Stuart David Maddison
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0