3C ASSET MANAGEMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02859913 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1390 Montpellier Court Gloucester Business Park GL3 4AH Brockworth Gloucester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ERINACEOUS PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 13. Dez. 2006 | 13. Dez. 2006 |
| SPRING GROVE PROPERTY MAINTENANCE LIMITED | 20. Juli 2006 | 20. Juli 2006 |
| SPRING GROVE PROPERTY MAINTENANCE PLC | 13. Okt. 1997 | 13. Okt. 1997 |
| SUPREMEJOB LIMITED | 06. Okt. 1993 | 06. Okt. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 11 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2023 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 11 Seiten | AA | ||
legacy | 171 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 13 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 25 Seiten | AA | ||
legacy | 184 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 24 Seiten | AA | ||
legacy | 163 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 24 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTRAN, Ben Robert | Sekretär | Montpellier Court Gloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Gloucester | British | 127102240001 | ||||||
| MILES, David John | Geschäftsführer | The Dormers Old Ashford Road Lenham ME17 2PX Maidstone Kent | England | British | 56094340001 | |||||
| SMITH, Andrew Christopher Melville | Geschäftsführer | The Old Bovey Main Road Shurdington GL51 4XJ Cheltenham Gloucestershire | England | British | 121328600001 | |||||
| WESTRAN, Ben Robert | Geschäftsführer | Montpellier Court Gloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Gloucester | United Kingdom | British | 127102240004 | |||||
| ASHTON, Frank Martin Scott | Sekretär | 48 Totteridge Drive Totteridge HP13 6JJ High Wycombe | British | 33907660004 | ||||||
| BELLIS, Juliet Mary Susan | Sekretär | 4 Grange Hill SE25 6SX London | British | 69991160002 | ||||||
| CHILDS, Kevin Joseph | Sekretär | 12 Curtis Road TW4 5PT Hounslow Middlesex | British | 59317330001 | ||||||
| GHADIALI, Hormuzd | Sekretär | 5 Channel Close TW5 0PJ Hounslow Middlesex | British | 80386350001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
| RAY, Clark Wilfred | Sekretär | 13 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | British | 14474030001 | ||||||
| WATSON, Robert Michael | Sekretär | Madselin House Misbourne Avenue SL9 0PD Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 59531700004 | ||||||
| YE, Christina Hong | Sekretär | Southview Cottages Newchapel Road RH7 6BJ Lingfield 5 Surrey | British | 133681410001 | ||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| BELLIS, Neil Graham | Geschäftsführer | 4 Grange Hill SE25 6SX London | British | 61569970002 | ||||||
| BERESFORD, Michael Eric | Geschäftsführer | 16 Sunnydene Avenue Highams Park E4 9RE London | British | 19710650002 | ||||||
| CHILDS, Kevin Joseph | Geschäftsführer | 55a Gloucester Road TW12 2UQ Hampton Middlesex | United Kingdom | British | 59317330002 | |||||
| CUFLEY, Sean Dominic Hardy | Geschäftsführer | Bank Cottage Haywards Heath Road Balcombe RH17 6NF Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 9150920001 | |||||
| CUMMINGS, Lucy | Geschäftsführer | 13 Plympton Street NW8 8AB London | British | 80559730001 | ||||||
| DAVIS, Nigel Peter | Geschäftsführer | 6 Boundary Park KT13 9RR Weybridge Surrey | England | British | 93673010002 | |||||
| DUNMAN, Jonathan Peter | Geschäftsführer | Willowbank Belbins SO51 0PE Romsey Hampshire | England | British | 40504320002 | |||||
| HARRISON, John | Geschäftsführer | Goodwin Manor Station Road CB5 0LG Swaffham Prior Cambridgeshire | British | 85872810001 | ||||||
| JENKINSON, Andrew Timothy | Geschäftsführer | Rosebery Avenue AL5 2QP Harpenden 16 Hertfordshire | United Kingdom | British | 74069620002 | |||||
| JOHNSON, Robin Simon | Geschäftsführer | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | England | British | 11498320001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MILNE, Andrew Robert | Geschäftsführer | 20 Hansler Grove KT8 9JN East Molesey Middlesex | British | 36619630004 | ||||||
| MILNE, Robert John | Geschäftsführer | 204 Brighton Road CR8 4HB Purley Surrey | United Kingdom | British | 19549950001 | |||||
| PEARSON, Michael | Geschäftsführer | 60 Barmouth Road SW18 2DR Wandsworth Greater London | England | British | 67026480004 | |||||
| PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Geschäftsführer | 17 Greenfield Drive Fortes Green N2 9AF London | England | British | 46176700002 | |||||
| RAY, Clark Wilfred | Geschäftsführer | 13 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | United Kingdom | British | 14474030001 | |||||
| REDBURN, Timothy John | Geschäftsführer | Little Abbotts Snower Hill Road RH3 7AQ Betchworth Surrey | England | British | 22018030002 | |||||
| SHORT, Derek William | Geschäftsführer | Vandeveldes La Rue De La Fontaine De Colard JE3 5DR Trinity Jersey | Jersey | British | 98194360001 | |||||
| WALKER, Alan | Geschäftsführer | Orchard Cottage 56 Summers Road GU7 3BD Farncombe Surrey | British | 81477210001 | ||||||
| WATSON, Robert Michael | Geschäftsführer | Madselin House Misbourne Avenue SL9 0PD Chalfont St Peter Buckinghamshire | England | British | 59531700004 | |||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mears Group Plc | 06. Apr. 2016 | Gloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Montpellier Court Gloucester United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat 3C ASSET MANAGEMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Erstellt am 02. Juni 2010 Geliefert am 10. Juni 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 26. Juli 2006 Geliefert am 03. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Mai 2004 Geliefert am 29. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 18. März 2004 Geliefert am 24. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of two thousand pounds and interest accrued thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 03. Dez. 2003 Geliefert am 16. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £7,512.66 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £7,512.66. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 08. Okt. 2003 Geliefert am 09. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit agreement | Erstellt am 08. Nov. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £1,875 or other the balance thereof for the time being pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 25. Juni 1999 Geliefert am 29. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over book debts | Erstellt am 17. Juli 1997 Geliefert am 23. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a financing agreement (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Fixed charge all book and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company other than such debts as the fator may have specifically agreed in writing to exclude from such fixed charge together with floating charge all book and other debts of the company not charge by way of fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. Dez. 1994 Geliefert am 13. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0