TWEED PREMIER 6 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTWEED PREMIER 6 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02862444
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TWEED PREMIER 6 LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich TWEED PREMIER 6 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cromwell House
    1-3 Fitzalan Place
    CF24 0ED Cardiff
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TWEED PREMIER 6 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SAVEASSET PUBLIC LIMITED COMPANY14. Okt. 199314. Okt. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TWEED PREMIER 6 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für TWEED PREMIER 6 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Graham Payne als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Graham Payne als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 21. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 2,500,002
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Robert Hodge als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2009

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2008

    11 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007

    13 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006

    17 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005

    15 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von TWEED PREMIER 6 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Sekretär
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Sekretär
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Sekretär
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    British59208430002
    CHILDS, Lisbeth Ann, Doctor
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    Sekretär
    17 Gay Street
    BA1 2PH Bath
    Avon
    British50515040002
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    DOWDESWELL, Jacqueline Anne
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    Sekretär
    54
    Lower Westwood
    BA15 2AE Bradford On Avon
    Wiltshire
    British50592080001
    GULHANE, Angeli Asha
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    Sekretär
    Flat 4
    3 Lansdown Crescent
    BA1 5EX Bath
    Avon
    British38173040001
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    British106162380001
    MACRAE, Alistair Ian
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    British71950710001
    PAYNE, Graham Charles
    6 Rhyd Y Penau Close
    CF14 0NF Llanishen
    Cardiff
    Sekretär
    6 Rhyd Y Penau Close
    CF14 0NF Llanishen
    Cardiff
    British2562330001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Sekretär
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    THE BRITISH LINEN BANK LIMITED
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    4 Melville Street
    EH3 7NZ Edinburgh
    Midlothian
    41450001
    BALLINGALL, Stuart James
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British57693580001
    BAMBER, Roger Stanley
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Whithorne Coach House
    London Road Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish2419370002
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Geschäftsführer
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    British18955940002
    BOND, Richard Keith
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    Geschäftsführer
    9 Cranford
    Brooklea Park Lisvane
    CF14 0XE Cardiff
    United KingdomBritish59208430002
    CASSELS, Alexander
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    634 Queensferry Road
    EH4 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    British566790001
    COLLINS, Roger
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    3 Hann Close
    BA5 2JR Wells
    Somerset
    British45885520003
    CRUICKSHANK, James Kerr
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    3 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    British46894940001
    HODGE, Robert John
    60 Pont Street
    SW1X 0AE London
    Flat C
    Geschäftsführer
    60 Pont Street
    SW1X 0AE London
    Flat C
    United KingdomBritish106162380003
    HODGE, Robert John
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Nant Fawr Graig Road
    Lisvane
    CF14 0UF Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish106162380001
    HUNTER, John Stewart
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    Geschäftsführer
    27 Queens Crescent
    EH9 2BA Edinburgh
    ScotlandBritish1127070001
    MURRAY, Edward Davidson
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish504780001
    ONEIL, James Charles
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    Geschäftsführer
    12 Antigua Street
    EH1 3NH Edinburgh
    British63521290001
    PAYNE, Graham Charles
    6 Rhyd Y Penau Close
    CF14 0NF Llanishen
    Cardiff
    Geschäftsführer
    6 Rhyd Y Penau Close
    CF14 0NF Llanishen
    Cardiff
    WalesBritish2562330001
    RADLEY, Alan John
    White Lion House
    5 New Street
    BA5 2LA Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    White Lion House
    5 New Street
    BA5 2LA Wells
    Somerset
    United KingdomBritish80260530003
    SMITH, Norman Alan
    18 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    18 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Midlothian
    British39538670001
    WHITAKER, David Alexander
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    ScotlandBritish26878690001
    YOUNG, Hugh Kenneth
    30 Braid Hills Road
    EH10 6HY Edinburgh
    Geschäftsführer
    30 Braid Hills Road
    EH10 6HY Edinburgh
    British529770001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Hat TWEED PREMIER 6 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2005
    Geliefert am 31. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2003
    Geliefert am 30. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    53 azalea close, ilford t/n EGL335122, 52 azalea close, ilford t/n EGL335124, 53 daffodil gardens, ilford t/n EGL336173 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    11 lochshot place eliburn livingstone t/no WLN11823 . all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F8 alexandra gate neilston road paisley t/no REN78517, G5 alexandra gate neilston road paisley t/no REN78625 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and
    Erstellt am 11. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    38 parkend gardens saltcoats comprising all and whole that dwellinghouse k/a flat number 38 parkend gardens rockpark court saltcaots being the southmost dwellinghouse on the ground floor of the three storey building or block for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries (The Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Dez. 2002
    Geliefert am 09. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee and the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) 52 azalea close,ilford; EGL335124; (ii) flat 153 lavender place,ilford IG1 2BG; EGL355424; (iii) 100 daffodil gardens,uphall rd,ilford; EGL336163; see form 395 for details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society,as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    33 parkend garden saltcoats. All and whole that dwellinghouse known as flat number 33 parkend gardens rockypark court saltcoats being the southmost dwellingshouse of the first floor above the ground floor of the three storey building or block comprising six dwellinghouses known as flat numbers 29, 30, 32, 33, 35 and 36 parkend gardens rockypark court. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F1 alexandria gate neilston road paisley PA2 6LN title number REN78518. F8 alexandra gate neilston road paisley PA2 6LN title number REN78517. G5 alexandra gate neilston road paisley PA2 6LN title number REN78625. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    11 hewitt place aberdour title number FFE17184.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and
    Erstellt am 30. Dez. 2002
    Geliefert am 04. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    11 lochshot place eliburn livingston title number WLN11823.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society, as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0