TWEED PREMIER 6 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TWEED PREMIER 6 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02862444 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TWEED PREMIER 6 LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich TWEED PREMIER 6 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Cromwell House 1-3 Fitzalan Place CF24 0ED Cardiff |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TWEED PREMIER 6 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SAVEASSET PUBLIC LIMITED COMPANY | 14. Okt. 1993 | 14. Okt. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TWEED PREMIER 6 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TWEED PREMIER 6 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Payne als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Payne als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Hodge als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TWEED PREMIER 6 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK, Lysanne Jane Warren | Sekretär | 6 Belgrave Crescent EH4 3AQ Edinburgh | British | 46707740002 | ||||||
| BOND, Richard Keith | Sekretär | 9 Cranford Brooklea Park Lisvane CF14 0XE Cardiff | British | 59208430002 | ||||||
| BOND, Richard Keith | Sekretär | 9 Cranford Brooklea Park Lisvane CF14 0XE Cardiff | British | 59208430002 | ||||||
| CHILDS, Lisbeth Ann, Doctor | Sekretär | 17 Gay Street BA1 2PH Bath Avon | British | 50515040002 | ||||||
| DIMENT, Peter Charles Michael | Sekretär | 4 Westfield Close CM23 2RD Bishops Stortford Hertfordshire | British | 32770400001 | ||||||
| DOWDESWELL, Jacqueline Anne | Sekretär | 54 Lower Westwood BA15 2AE Bradford On Avon Wiltshire | British | 50592080001 | ||||||
| GULHANE, Angeli Asha | Sekretär | Flat 4 3 Lansdown Crescent BA1 5EX Bath Avon | British | 38173040001 | ||||||
| HODGE, Robert John | Sekretär | Nant Fawr Graig Road Lisvane CF14 0UF Cardiff South Glamorgan | British | 106162380001 | ||||||
| MACRAE, Alistair Ian | Sekretär | 32 The Steils EH10 5XD Edinburgh Midlothian | British | 71950710001 | ||||||
| PAYNE, Graham Charles | Sekretär | 6 Rhyd Y Penau Close CF14 0NF Llanishen Cardiff | British | 2562330001 | ||||||
| SAUNDERS, Timothy, Mr. | Sekretär | Beckets Place Marksbury BA2 9HP Bath Avon | British | 47952140001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| THE BRITISH LINEN BANK LIMITED | Sekretär | 4 Melville Street EH3 7NZ Edinburgh Midlothian | 41450001 | |||||||
| BALLINGALL, Stuart James | Geschäftsführer | 78/10 Orchard Brae Avenue EH4 2GA Edinburgh Midlothian Scotland | British | 57693580001 | ||||||
| BAMBER, Roger Stanley | Geschäftsführer | Whithorne Coach House London Road Charlton Kings GL52 6UY Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 2419370002 | |||||
| BARKLEY, John | Geschäftsführer | 10 Willow Tree Place The Beeches EH14 5AZ Balerno Edinburgh, Midlothian | British | 18955940002 | ||||||
| BOND, Richard Keith | Geschäftsführer | 9 Cranford Brooklea Park Lisvane CF14 0XE Cardiff | United Kingdom | British | 59208430002 | |||||
| CASSELS, Alexander | Geschäftsführer | 634 Queensferry Road EH4 6DZ Edinburgh Midlothian | British | 566790001 | ||||||
| COLLINS, Roger | Geschäftsführer | 3 Hann Close BA5 2JR Wells Somerset | British | 45885520003 | ||||||
| CRUICKSHANK, James Kerr | Geschäftsführer | 3 Mid Steil Glenlockhart EH10 5XB Edinburgh Midlothian | British | 46894940001 | ||||||
| HODGE, Robert John | Geschäftsführer | 60 Pont Street SW1X 0AE London Flat C | United Kingdom | British | 106162380003 | |||||
| HODGE, Robert John | Geschäftsführer | Nant Fawr Graig Road Lisvane CF14 0UF Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 106162380001 | |||||
| HUNTER, John Stewart | Geschäftsführer | 27 Queens Crescent EH9 2BA Edinburgh | Scotland | British | 1127070001 | |||||
| MURRAY, Edward Davidson | Geschäftsführer | 27 Barnshot Road EH13 0DJ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 504780001 | |||||
| ONEIL, James Charles | Geschäftsführer | 12 Antigua Street EH1 3NH Edinburgh | British | 63521290001 | ||||||
| PAYNE, Graham Charles | Geschäftsführer | 6 Rhyd Y Penau Close CF14 0NF Llanishen Cardiff | Wales | British | 2562330001 | |||||
| RADLEY, Alan John | Geschäftsführer | White Lion House 5 New Street BA5 2LA Wells Somerset | United Kingdom | British | 80260530003 | |||||
| SMITH, Norman Alan | Geschäftsführer | 18 Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh Midlothian | British | 39538670001 | ||||||
| WHITAKER, David Alexander | Geschäftsführer | Duncrievie PH2 9PD Glenfarg Perthshire | Scotland | British | 26878690001 | |||||
| YOUNG, Hugh Kenneth | Geschäftsführer | 30 Braid Hills Road EH10 6HY Edinburgh | British | 529770001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
Hat TWEED PREMIER 6 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 16. Aug. 2005 Geliefert am 31. Aug. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 30. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 53 azalea close, ilford t/n EGL335122, 52 azalea close, ilford t/n EGL335124, 53 daffodil gardens, ilford t/n EGL336173 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 23. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 11 lochshot place eliburn livingstone t/no WLN11823 . all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 23. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F8 alexandra gate neilston road paisley t/no REN78517, G5 alexandra gate neilston road paisley t/no REN78625 for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 3RD november 2004 and | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 23. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them or the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 38 parkend gardens saltcoats comprising all and whole that dwellinghouse k/a flat number 38 parkend gardens rockpark court saltcaots being the southmost dwellinghouse on the ground floor of the three storey building or block for details of further property charged please refer to form 395. all buildings fixtures and fixed plant and machinery. Assigned the goodwill insurances and appointment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities and obligations due or to become due from the company (the "chargor") to the chargee and the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (I) 52 azalea close,ilford; EGL335124; (ii) flat 153 lavender place,ilford IG1 2BG; EGL355424; (iii) 100 daffodil gardens,uphall rd,ilford; EGL336163; see form 395 for details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and | Erstellt am 30. Dez. 2002 Geliefert am 04. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 33 parkend garden saltcoats. All and whole that dwellinghouse known as flat number 33 parkend gardens rockypark court saltcoats being the southmost dwellingshouse of the first floor above the ground floor of the three storey building or block comprising six dwellinghouses known as flat numbers 29, 30, 32, 33, 35 and 36 parkend gardens rockypark court. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and | Erstellt am 30. Dez. 2002 Geliefert am 04. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F1 alexandria gate neilston road paisley PA2 6LN title number REN78518. F8 alexandra gate neilston road paisley PA2 6LN title number REN78517. G5 alexandra gate neilston road paisley PA2 6LN title number REN78625. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and | Erstellt am 30. Dez. 2002 Geliefert am 04. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 11 hewitt place aberdour title number FFE17184. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 16TH january 2003 and | Erstellt am 30. Dez. 2002 Geliefert am 04. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 11 lochshot place eliburn livingston title number WLN11823. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0