WGP 100 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWGP 100 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02865476
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WGP 100 LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich WGP 100 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    27 Baker Street
    W1U 8AH London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WGP 100 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WESTON MEDICAL LIMITED01. Feb. 199401. Feb. 1994
    SORDINI LIMITED25. Okt. 199325. Okt. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WGP 100 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Jan. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WGP 100 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung am 20. Juni 2011

    • Kapital: GBP 0.01
    4 SeitenSH19

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John King am 18. Okt. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Jan. 2010

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr John King am 16. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Anthony Gifford am 12. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John King am 29. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Donald Mccarthy am 29. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Anthony Gifford am 29. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Geoffrey Hearsey am 29. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES
    capital

    Beschlüsse

    Auth to sign accounts 18/06/2009
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Jan. 2009

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Jan. 2008

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von WGP 100 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HEARSEY, Peter Geoffrey
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Sekretär
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    British100685710010
    GIFFORD, Mark Anthony
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritish87902570004
    KING, John
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritish119328820004
    MCCARTHY, Donald
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    United Kingdom
    United KingdomBritish115152280003
    BATES, David Priestley
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    Sekretär
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    British22204560001
    MALLETT, Andrew
    29 Saint Jamess Drive
    SW17 7RN London
    Sekretär
    29 Saint Jamess Drive
    SW17 7RN London
    British86193030001
    POMEROY, Julie Patricia
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    British87703450001
    THOMSON, Christopher John
    Bramblefield House
    Station Hill, Little Whelnetham
    IP30 0DT Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    Bramblefield House
    Station Hill, Little Whelnetham
    IP30 0DT Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British72127780002
    WAINE, Ian Michael
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    Sekretär
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    British93513490001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish55757700003
    BATES, David Priestley
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Common Barn Mill Lane
    Stradbroke
    IP21 5HW Eye
    Suffolk
    British22204560001
    BLAKER, Graham Joseph, Dr
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish110270002
    BODNAR-HORVATH, Robert Edmund Paul
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    Geschäftsführer
    20 Harold Road
    SE19 3PL London
    EnglandBritish46232460002
    CASSAR, Stefan John
    22 Hazelwell Road
    SW15 6HL London
    Geschäftsführer
    22 Hazelwell Road
    SW15 6HL London
    EnglandBritish117062050001
    COLEMAN, John
    Lodge House Lodge House Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Geschäftsführer
    Lodge House Lodge House Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish56366250008
    DRAKE, John Arthur Courtney
    Manor Farm
    Witcombe
    TA12 6AJ Martock
    Somerset
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Witcombe
    TA12 6AJ Martock
    Somerset
    EnglandBritish86344060001
    GIBBONS, David
    165 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AX London
    Geschäftsführer
    165 Elm Park Mansions
    Park Walk
    SW10 0AX London
    United KingdomBritish68823520001
    GORST, Jonathan Edward
    St Marys Main Road
    Martlesham
    IP12 4SJ Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    St Marys Main Road
    Martlesham
    IP12 4SJ Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish36521390001
    HOLLIDAY, Michael Francis
    Grange Farm
    Harvest Lane, Hindringham
    NR21 0PW Fakenham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Grange Farm
    Harvest Lane, Hindringham
    NR21 0PW Fakenham
    Norfolk
    EnglandBritish24337350002
    KING, Toby St John, Dr
    33 Maids Causeway
    CB5 8DE Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    33 Maids Causeway
    CB5 8DE Cambridge
    Cambridgeshire
    British80054230001
    MANN, Khawar Amin
    107 Bramfield Road
    SW11 6PZ London
    Geschäftsführer
    107 Bramfield Road
    SW11 6PZ London
    British80214180001
    NEWMARCH, Michael George
    27 Paultons Square
    SW3 5DS London
    Geschäftsführer
    27 Paultons Square
    SW3 5DS London
    British1109560002
    POMEROY, Julie Patricia
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Shielings
    Highgrove Gardens
    NG12 4DF Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish87703450001
    SAMLER, Christopher Hadley
    The Old Rectory
    Creeton
    NG33 4QB Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Creeton
    NG33 4QB Grantham
    Lincolnshire
    EnglandBritish54818550001
    SPICKSCHEN, Thorlef, Dr
    Traubenweg 25
    Seeheim
    64342
    Germany
    Geschäftsführer
    Traubenweg 25
    Seeheim
    64342
    Germany
    German80135950001
    WAINE, Ian Michael
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    Geschäftsführer
    The Spinney
    High Road Great Finborough
    IP14 3AA Stowmarket
    Suffolk
    United KingdomBritish93513490001
    WESTON, Terence Edward
    Swannington Hall
    Church Lane, Swannington
    NR9 5NP Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Swannington Hall
    Church Lane, Swannington
    NR9 5NP Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish86432990001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Hat WGP 100 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 05. Jan. 2000
    Geliefert am 11. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £8,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The sum of £8,000.
    Berechtigte Personen
    • East of England Development Agency
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit agreement
    Erstellt am 17. Feb. 1999
    Geliefert am 19. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £4,582.00 standing to the credit of the deposit account opened by the landlord's solocitors rogers & norton with barclays bank PLC plain norwich norfolk from time to time
    Kurze Angaben
    Rent deposit agreement under lease dated 5/2/99 in respect of unit 4B fuller road industrial estate fuller rd,harleston norfolk.
    Berechtigte Personen
    • David Jenkinson and Mary Ann Jenkinson
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge of intellectual property rights
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 12. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as trustee on behalf of the loan investors (as defined) and the noteholders (as defined) and to the noteholders and loan investors pursuant to the deed and/or the investments agreement and/or pursuant to the loan instrument
    Kurze Angaben
    All patents and applications for patents,all intellectual property rights all rights title and interest in the trade marks all the materials for full details of charged assets please refer to form 395 (part iii of the schedule to the form). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 12. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in it's capacity as security trustee for the loan investors (as defined) and the noteholders (as defined) and to any of the loan investors and the noteholders pursuant to the loan instrument
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed of mortgage
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 11. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the investment agreement, the supplemental investment agreement and/or the deed of mortgage as supplemented by the supplemental deed of mortgage
    Kurze Angaben
    (A) save in respect of the intellectual property rights charged pursuant to clause 3.1(d) of the deed of mortgage has assigned absolutely to the lender to the extent that such rights are capable of assignment all of the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding expressly the third party rights but subject to and with benefit of the existing exploitation agreement to hold the same to the lender its successors and assigns absolutely for the free period during which such rights subsist throughout the world subject to the company's right of redemption pursuant to clause 6 of the deed of mortgage. Where any of the assigned rights are executory such assignment shall be construed as a present assignment of future rights;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canven (C.I.) Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge of intellectual property rights and floating charge
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 11. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights, all of the materials together with all of the equipment, by way of first floating charge the undertaking and all property and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 11. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the investment agreement and/or the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canven (C.I.) Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 03. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an investment agreement dated 25TH september 1997 or under the debenture itself
    Kurze Angaben
    Assignment of intellectual property rights with benefit of exploitation thereof undertaking to hold on trust those which cannot be assigned fixed charge on physical materials plant machinery and equipment intellectual property rights applications for such rights and book debts of the company. Equitable charge on physical materials to be created. Floating charge on all other assets.
    Berechtigte Personen
    • Michael Francis Holliday
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 1997
    Geliefert am 03. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an investment agreement dated 25TH september 1997 or under the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Michael Francis Holliday
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 18. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the investment agreement and/or this deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canven (C.I.) Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 18. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the investment agreement and/or this deed
    Kurze Angaben
    Part of the physcial materials charges all plant machinery and equipment relating to the intellectual property rights or the third party rights or the physical materials all the intellectual property rights all book debts and other debts floating charge over the undertaking and property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canven (C.I.) Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of and fixed charge over intellectual property rights
    Erstellt am 06. Aug. 1996
    Geliefert am 23. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all other sums intended to be secured in deeds of assignment of intellectual property rights and floating charges dated 14TH january 1994, 2ND october 1995 and 10TH april 1996 (the "previous deeds")
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all the company's right title and interest in and to (a). The patents and (b) the intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Erstellt am 10. Apr. 1996
    Geliefert am 12. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of all of the company's right, title and interest in and to the intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights and floating charge
    Erstellt am 02. Okt. 1995
    Geliefert am 19. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest in and to the intellectual property rights floating charge over all the other undertaking and other property assets of the company present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of intellectual property rights andfloating charge
    Erstellt am 14. Jan. 1994
    Geliefert am 21. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of all the company's right title and interest in and to the intellectual,property rights as specified. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Jan. 1994
    Geliefert am 19. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WGP 100 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Feb. 2003Beginn der Verwaltung
    14. Juni 2005Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Allan Watson Graham
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Praktiker
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Jane Bronwen Moriarty
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praktiker
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    2
    DatumTyp
    28. Nov. 2003Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    13. Mai 2005Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Allan Watson Graham
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Praktiker
    Acquis Court
    31 Fishpool Street
    AL3 4RF St Albans
    Jane Bronwen Moriarty
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praktiker
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0