TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02866179 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ACDTRIDON EUROPE LIMITED | 29. Mai 1996 | 29. Mai 1996 |
| AUTOMOTIVE COMPONENTS DUNSTABLE LIMITED | 14. Dez. 1993 | 14. Dez. 1993 |
| PIRGOS LIMITED | 26. Okt. 1993 | 26. Okt. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Coral Suzanne Bidel als Geschäftsführer am 22. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Marc Richard Jaffe als Geschäftsführer am 09. Juli 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU zum Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY am 12. Dez. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Insolvenzbeschluss Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 Seiten | LIQ MISC RES | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 10. Okt. 2014
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicolas Paul Wilkinson als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas C. Reeve als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Honor Lewzey als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Coral Bidel am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Daniel Marc Richard Jaffe als Direktor am 13. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Intertrust (Uk) Limited als Sekretär am 13. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Ernennung von Miss Coral Bidel als Direktor am 13. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Honor Lewzey als Sekretär am 13. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE zum 11 Old Jewry 7Th Floor London EC2R 8DU am 22. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Sekretär | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom |
| 188126550001 | ||||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Sekretär | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Sekretär | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157101930001 | |||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Sekretär | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833360001 | |||||||||||
| SHORTT, Eugene | Sekretär | 50 Green Drift SG8 5BX Royston Hertfordshire | British | 4764420001 | ||||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Sekretär | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000940001 | |||||||||||
| ABBOTT, Brian Arthur | Geschäftsführer | 18 Alma Farm Road Toddington LU5 6BG Dunstable Bedfordshire | England | British | 38296100001 | |||||||||
| BIDEL, Coral Suzanne | Geschäftsführer | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 179297460002 | |||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Geschäftsführer | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||||||
| CAREY, Stephen James | Geschäftsführer | 145 High Street Harrold MK43 7ED Bedford Bedfordshire | British | 76189900002 | ||||||||||
| CORPATAUX, Beat Eugene | Geschäftsführer | Marly Strasse 3 CH 17 34 Tentlingen Switzerland | Switzerland | Swiss | 49248640001 | |||||||||
| DRUMMOND, David Fraser | Geschäftsführer | 3 St Anthony's Close RG12 2EB Bracknell Berkshire | British | 43960000001 | ||||||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Geschäftsführer | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||||||
| HILLSON, Anthony Leonard | Geschäftsführer | 18 Tavistock Avenue Ampthill MK45 2RY Bedford | British | 43960090001 | ||||||||||
| HOFMANN, Helmut | Geschäftsführer | 12 Meadow Height Crt L4J 1V6 Thornhill Ontario Canada | Canadian | 46601750001 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Geschäftsführer | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||||||
| HOTTINGER, Michael | Geschäftsführer | 5000 Country Club Drive 37027 Brentwood Tennessee Usa | American | 46550450001 | ||||||||||
| JAFFE, Daniel Marc Richard | Geschäftsführer | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 140811810001 | |||||||||
| KEECH, Craig William | Geschäftsführer | 174 Slad Road GL5 1RJ Stroud Gloucestershire | British | 45367870003 | ||||||||||
| KEECH, Dennis | Geschäftsführer | 216 Old Bedford Road LU2 7HP Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 24425650001 | |||||||||
| KEECH, Matthew David | Geschäftsführer | 36 Statham Close LU3 4EJ Luton Bedfordshire | British | 38296150001 | ||||||||||
| KINGSBURGH, Murray | Geschäftsführer | 31 Warlock Crescent MKU 2H8 Willowdale Ontario Canada | Canadian | 46550570001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Geschäftsführer | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LANGSHAW, Ralph | Geschäftsführer | Westway 71a West Common AL5 2LD Harpenden Hertfordshire | British | 37169710001 | ||||||||||
| LEE, Norman Holt | Geschäftsführer | 9 Compgate Eaton Bray LU6 2AU Dunstable Bedfordshire | British | 38296170001 | ||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Geschäftsführer | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Geschäftsführer | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||||||
| MUSHTAQ, Mohammed Arif | Geschäftsführer | 13 Edkins Close Bushmead LU2 7SS Luton Bedfordshire | British | 42865020001 | ||||||||||
| PORTER, Norman Charles | Geschäftsführer | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||||||
| REEVE, Thomas C. | Geschäftsführer | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||||||
| RENNER, James | Geschäftsführer | 3453 Sawmill Valley Drive LSL 3A3 Mississauga Ontario Canada | Canadian | 46550730001 | ||||||||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Geschäftsführer | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||||||
| YEOMANS, Alan Richard | Geschäftsführer | 16 Long Massey MK46 5NR Olney Buckinghamshire | British | 26276020001 | ||||||||||
| CMH DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000930001 |
Hat TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Erstellt am 30. Sept. 2010 Geliefert am 15. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 30. Sept. 2010 Geliefert am 13. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Feb. 1996 Geliefert am 23. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from tridon limited,the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben All right title estate and other interests of the chargor in or over a lease dated 29TH january 1996 of land and buildings situate on the south west of high street north dunstable bedfordshire and all plant and machinery and all assets charged and assigned as outlined on the form 395 and attached schedules please see form for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Feb. 1994 Geliefert am 16. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The assigns the goodwill of the business to the bank the benefit of any licences all intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage and specific charge | Erstellt am 08. Feb. 1994 Geliefert am 16. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and every interest in or over a lease dated 4/2/94 of land and buildings on the south west of high street north dunstable bedfordshire and situate and k/a the waterloo sports ground high street north dunstable bedfordshire t/no'SBD95171 and BD26409 all rights under an option agreement dated 4/2/94. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TRICO PRODUCTS (DUNSTABLE) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0