SIX PIERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSIX PIERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02866408
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SIX PIERS LIMITED?

    • Andere Vergnügungs- und Erholungsaktivitäten n.a. (93290) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich SIX PIERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Lynton House Ackhurst Park
    Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SIX PIERS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROWN ENTERTAINMENT CENTRES LTD08. Jan. 200408. Jan. 2004
    CROWN GAMING LIMITED11. Sept. 200111. Sept. 2001
    SOLNEY AUTOMATIC SERVICES LIMITED27. Okt. 199327. Okt. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIX PIERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für SIX PIERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    11 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 05. Juni 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Craig John Hemmings am 05. Juni 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Mark Lorimer Widders am 05. Juni 2017

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Gleadhill House Dawbers Lane Euxton Chorley Lancashire PR7 6EA zum Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road Chorley Lancashire PR7 1NY am 09. Juni 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Mark Lorimer Widders als Sekretär am 31. Dez. 2015

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Craig John Hemmings als Direktor am 31. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von St John Stott als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von St John Stott als Sekretär am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM02

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Mark Lorimer Widders als Direktor am 11. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Dean Leonard Harding als Geschäftsführer am 16. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    13 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed crown entertainment centres LTD\certificate issued on 18/11/14
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 07. Nov. 2014

    RES15

    Wer sind die Geschäftsführer von SIX PIERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Sekretär
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    203881770001
    HEMMINGS, Craig John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    United KingdomBritishCompany Director180952730001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    EnglandBritishDirector2272770002
    HOWE, Iris
    7 Eton Court
    West Hallam
    DE7 6NB Ilkeston
    Derbyshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    7 Eton Court
    West Hallam
    DE7 6NB Ilkeston
    Derbyshire
    British900002250001
    OBYRNE, Elaine
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    British41490750001
    OBYRNE, Elaine
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    British41490750001
    OBYRNE, Kenneth Gerald
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishDirector29155170001
    OBYRNE, Kenneth Gerald
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishDirector29155170001
    PARKIN, Keith
    14 Brothercross Way
    PE38 9RF Downham Market
    Norfolk
    Sekretär
    14 Brothercross Way
    PE38 9RF Downham Market
    Norfolk
    British72524600001
    RODEN, Paul Andrew
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    Sekretär
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    BritishFinance Director40949300001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Sekretär
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    BritishAccountant83024660001
    WALKER, David
    55 Bramcote Road
    LE11 2SA Loughborough
    Leicestershire
    Sekretär
    55 Bramcote Road
    LE11 2SA Loughborough
    Leicestershire
    British41537310001
    GEMSON, Michael
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    BritishDirector363340001
    HARDING, Dean Leonard
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector58933060001
    HOWE, Kenneth
    7 Eton Court
    West Hallam
    DE7 6NB Ilkeston
    Derbyshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    7 Eton Court
    West Hallam
    DE7 6NB Ilkeston
    Derbyshire
    British900002240001
    OBYRNE, Kenneth Gerald
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    38 The Meadows
    Kingstone
    ST14 8QE Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishDirector29155170001
    RODEN, John Keith Dennis
    Crowshaws House The Barn
    Little Scotland Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Crowshaws House The Barn
    Little Scotland Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director1771410001
    RODEN, Paul Andrew
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishFinance Director40949300001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector83024660001
    TURNER, Kenneth Bryan
    Lynton Longsight Road
    Clayton Le Dale
    BB2 7JA Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Lynton Longsight Road
    Clayton Le Dale
    BB2 7JA Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director29183950001
    WALKER, David
    55 Bramcote Road
    LE11 2SA Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    55 Bramcote Road
    LE11 2SA Loughborough
    Leicestershire
    BritishDirector41537310001
    WILCOX, David Richard
    6 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    6 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishDirector15988380001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SIX PIERS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Cuerden Leisure Limited
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    England
    06. Apr. 2016
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageEngland
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SIX PIERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed, supplemental to a debenture dated 18TH june 1999, issued by the company
    Erstellt am 22. Dez. 1999
    Geliefert am 12. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All or any monies and liabilities which will for the time being (and whether on or at any time after demand) be due, owing or incurred in whatsoever manner to the chargee by the company, whether actually or contingently, soley or jointly and whether as principal or surety and whether or not bos shall have been an original party to the relevant transaction, and including interest, discount, commission and other lawful charges or expenses which bos may in the course of its business charge or incur in respect of any of those matters or for keeping the company's account, and so that interest shall be computed and compounded according to the usual bos rates and practice as well after as well as before any demand made or decree obtained under the debenture ("the secured liabilities")
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("Bos")
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 1999
    Geliefert am 29. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Juli 1997
    Geliefert am 30. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 01. Feb. 1994
    Geliefert am 07. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 23. Dez. 1993
    Geliefert am 10. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0