AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02870861 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED?
- (4533) /
- (7415) /
Wo befindet sich AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rok Centre Guardian Road Exeter Business Park EX1 3PD Exeter Devon |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AVONSIDE GAS SERVICES LIMITED | 05. Dez. 2001 | 05. Dez. 2001 |
| AVONSIDE SERVICES LIMITED | 12. Apr. 1994 | 12. Apr. 1994 |
| ATLANTIC SHELF 60 LIMITED | 10. Nov. 1993 | 10. Nov. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Turnbull als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sandra Al-Kordi als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sandra Joan Al-Kordi als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Turnbull als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Julian Patrick Turnbull als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ashley Martin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Garvis Snook als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Batty als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Michael Batty am 30. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 24 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 22 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 7 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 24 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-KORDI, Sandra Joan | Sekretär | Rok Centre Guardian Road Exeter Business Park EX1 3PD Exeter Devon | 148910380001 | |||||||
| BATTY, Stephen Michael | Sekretär | 46 Nornabell Drive Kingsley Park Molescroft HU17 9GJ Beverley | British | 61237770002 | ||||||
| GREEN, David William | Sekretär | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | British | 38923390001 | ||||||
| MURPHY, John | Sekretär | 17 Durisdeer Drive ML3 8XB Hamilton Lanarkshire | British | 37375030001 | ||||||
| TURNBULL, Julian Patrick | Sekretär | The Knoll Marsh Green EX5 2ES Exeter Devon | English | 11548360002 | ||||||
| WILD, Pamela Jayne | Sekretär | 4 Pendine Close Callands WA5 5RQ Warrington Cheshire | British | 64167100001 | ||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| BATTY, Stephen Michael | Geschäftsführer | 46 Nornabell Drive Kingsley Park Molescroft HU17 9GJ Beverley | United Kingdom | British | 61237770002 | |||||
| BURKE, Anthony | Geschäftsführer | 5 Stanney Close Milnrow OL16 4BF Rochdale Lancashire | British | 58500120001 | ||||||
| BURKE, Anthony | Geschäftsführer | 5 Stanney Close Milnrow OL16 4BF Rochdale Lancashire | British | 58500120001 | ||||||
| DICKINSON, Ronald William | Geschäftsführer | 5 Ashworth Drive HU10 7NF Kirkella East Yorkshire | British | 25252540003 | ||||||
| GREEN, David William | Geschäftsführer | 22 Hornchurch Drive PR7 2RJ Chorley Lancashire | United Kingdom | British | 38923390001 | |||||
| MARTIN, Ashley Graham | Geschäftsführer | Spencers Farm Whelpley Hill HP5 3RP Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 116805870001 | |||||
| MURRAY, Stephen | Geschäftsführer | Went View Great North Road WF8 3JP Wentbridge West Yorkshire | United Kingdom | British | 90170480001 | |||||
| SLATER, Richard Craig Alan | Geschäftsführer | Timbers The Spinney Springfield Lane LL12 8TG Marford Clwyd | British | 37111560003 | ||||||
| SNOOK, Garvis David | Geschäftsführer | Sloane Gardens SW1W 8EB London 13 | England | British | 70647210004 | |||||
| TURNBULL, Julian Patrick | Geschäftsführer | Rok Centre Guardian Road Exeter Business Park EX1 3PD Exeter Devon | United Kingdom | British | 148730570001 | |||||
| WALKER, Jonathan James | Geschäftsführer | Haberfield Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster Lancashire | England | British | 39444010001 | |||||
| WALKER, Malcolm Charles | Geschäftsführer | Hotham House Main Street YO4 3UD Hotham York | British | 38923580001 | ||||||
| MD DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow Pacific House | 900005100001 |
Hat AVONSIDE CONTRACT SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Erstellt am 30. Sept. 2009 Geliefert am 06. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. März 2009 Geliefert am 24. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any company to any pension scheme or to any pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben St james retail and business park knaresborough harrowgate t/no NYK352109 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. März 2009 Geliefert am 16. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Feb. 2006 Geliefert am 01. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 11. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 11. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 11. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0