ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED

ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02870868
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen

    Wo befindet sich ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 High Street
    LU7 1EA Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2014

    8 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2014 bis 30. Apr. 2014

    3 SeitenAA01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Malcolm Mccann als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Malcolm Mccann als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Änderung der Details des Sekretärs für Carole Margaret Thompson am 01. Apr. 2011

    3 SeitenCH03

    Ernennung von Carole Thompson als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Graham Peter Mccann als Direktor

    3 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 6 Corunna Court Corunna Road Warwick CV34 5HQ* am 28. Feb. 2014

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2010

    10 SeitenAA

    Antrag auf administrative Wiederherstellung

    3 SeitenRT01

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm John Mccann am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THOMPSON, Carole Margaret
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    Sekretär
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    British114981070001
    MCCANN, Graham Peter
    Stanbridge
    LU7 9JF Leighton Buzzard
    24
    Beds
    England
    Geschäftsführer
    Stanbridge
    LU7 9JF Leighton Buzzard
    24
    Beds
    England
    EnglandBritish10443110001
    THOMPSON, Carole
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    30b
    Bedfordshire
    EnglandBritish185541220001
    JEWELL, Barrie
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Sekretär
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British73013500001
    MCCANN, Malcolm John
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    Sekretär
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    British37465650002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    Sekretär
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    British37465650002
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    JEWELL, Barrie
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    9 Rothschild Road
    LU7 7SY Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British73013500001
    MCCANN, Kevin Stephen
    Springvale 67 Soulbury Road
    Linslade
    LU7 7RW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Springvale 67 Soulbury Road
    Linslade
    LU7 7RW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British76094280002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    Geschäftsführer
    Branscombe
    28b Mentmore Road
    LU7 2NZ Leighton Buzzard
    EnglandBritish37465650002
    SIERS, Michael John
    12 Mentmore Gardens
    LU7 7LT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    12 Mentmore Gardens
    LU7 7LT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British37596840001
    DOUGLAS NOMINEES LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    900007880001

    Hat ROSEBURY DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 2006
    Geliefert am 10. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    68 mentmore road linslade leighton buzzard bedfordshire t/n BD53213. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 23. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H castle house old road linslade leighton buzzard bedforshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Okt. 1998
    Geliefert am 15. Okt. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 11 southcott ave,linsdale leighton buzzard bedfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Aug. 1998
    Geliefert am 02. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as building plot to the rear of 19 london road stoney stratford milton keynes; see form 395. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. März 1998
    Geliefert am 11. März 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 24 rock lane linslade leighton buzzard bedfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Sept. 1997
    Geliefert am 04. Sept. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H known as the warehouse new road linsdale leighton buzzard bedfordshire t/n BD72857. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Juni 1997
    Geliefert am 09. Juni 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a plot 23 cloud berry walnut tree milton keynes.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Jan. 1997
    Geliefert am 04. Feb. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a land adjacent to railway cottages mentmore road leighton buzzard bedfordshire t/n BD127156 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1996
    Geliefert am 06. Sept. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as 2 belsize avenue springfield milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juli 1996
    Geliefert am 08. Juli 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/as plot 32 cloudberry walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 1996
    Geliefert am 05. März 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a plot 33 cloudberry, walnut tree, milton keynes, buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Sept. 1995
    Geliefert am 15. Sept. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 34 clodbury walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Mai 1995
    Geliefert am 01. Juni 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 6 cloudberry walnut tree milton keynes bucks and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Apr. 1995
    Geliefert am 07. Apr. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as plot 35 cloudberry walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Aug. 1994
    Geliefert am 02. Sept. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a plot 36 cloudberry walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 11. März 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a plot 37 cloudberry postal address 17 tatling grove walnut tree milton keynes buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0