EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02871212 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED?
- Andere berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten n.a. (74909) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Church House 13-15 Regent Street NG1 5BS Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| E.E.C. BUILDING SERVICES LIMITED | 12. Nov. 1993 | 12. Nov. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 15 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 14 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2018 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2017 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit C17 Kestrel Business Centre Private Road 2 Colwick Industrial Estate Nottingham NG4 2JR zum Church House 13-15 Regent Street Nottingham NG1 5BS am 19. Apr. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit V15 Lenton Busness Centre Lenton Boulevard Nottingham NG7 2BY zum Unit C17 Kestrel Business Centre Private Road 2 Colwick Industrial Estate Nottingham NG4 2JR am 09. Nov. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Penrhyn Wynne am 26. Okt. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher Paul Barraclough am 23. Okt. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Christopher Paul Barraclough am 07. Nov. 2013 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4 the Moorings Mossley Ashton Under Lyne Lancashire OL5 9BZ* am 29. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRACLOUGH, Christopher Paul | Sekretär | 13-15 Regent Street NG1 5BS Nottingham Church House | British | 98177580001 | ||||||
| BARRACLOUGH, Christopher Paul | Geschäftsführer | 13-15 Regent Street NG1 5BS Nottingham Church House | England | British | 98177580001 | |||||
| WYNNE, Stephen Penrhyn | Geschäftsführer | 13-15 Regent Street NG1 5BS Nottingham Church House | England | British | 39825150002 | |||||
| ALDERSON, Stephen John | Sekretär | 4 The Moorings Mossley OL5 9BZ Ashton Under Lyne Lancashire | British | 41800270001 | ||||||
| KITCHIN, Margaret Olive | Sekretär | 79 Arundel Drive Bramcote Hills NG9 3FN Nottingham Nottinghamshire | British | 85911600001 | ||||||
| ROBINSON, Stephen Alan | Sekretär | 13 Oak Avenue Royton OL2 6TB Oldham Lancashire | British | 52196110001 | ||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| JONES, Edward | Geschäftsführer | Dingle View Hollins Road Waterhead OL4 3SG Oldham Lancashire | British | 48666310001 | ||||||
| KITCHIN, Robert Grahame | Geschäftsführer | 79 Arundel Drive Bramcote Hils NG9 3FN Nottingham Nottinghamshire | British | 45365710001 | ||||||
| MORRISON, Neil Arthur Robert | Geschäftsführer | 50 Somerset Grove OL11 5YS Rochdale Lancashire | British | 10817520002 | ||||||
| O'BRIEN, Patrick Gerard | Geschäftsführer | The Rise 15 Oughtrington Lane WA13 0QY Lymm Cheshire | Irish | 4879500007 | ||||||
| O'BRIEN, Patrick Gerard | Geschäftsführer | 918 Oldham Road Thornham OL11 2BN Rochdale Lancashire | Irish | 4879500002 | ||||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Hat EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Nov. 2010 Geliefert am 04. Dez. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 41 lansdown road gloucester t/n GR69807, with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. Aug. 2007 Geliefert am 14. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property plot 3 lime grove welland malvern worcestershire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Okt. 2005 Geliefert am 22. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H former job centre head street pershore. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Apr. 2005 Geliefert am 29. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EEC CONSTRUCTION SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0