MAINCOURSE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAINCOURSE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02872758
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAINCOURSE LIMITED?

    • (7011) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich MAINCOURSE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    63 Walter Road
    SA1 4PT Swansea
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAINCOURSE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAINCOURSE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    9 Seiten4.72

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 11. Juli 2011

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 62 Newport Road Cardiff CF24 0RF am 28. Juni 2011

    2 SeitenAD01

    legacy

    2 SeitenLQ01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Dez. 2010

    Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2009

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2008

    13 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Debra Ann Stanley am 01. Okt. 2009

    3 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2007

    16 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2006

    16 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2005

    16 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    9 Seiten395

    legacy

    6 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von MAINCOURSE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STANLEY, Debra Ann
    Whitehead Estate
    Docks Way
    NP20 2NW Newport
    Coilcolor Bldg
    South Wales
    Sekretär
    Whitehead Estate
    Docks Way
    NP20 2NW Newport
    Coilcolor Bldg
    South Wales
    British82725480001
    JENKINS, Edward Keith
    Valley View Main Road
    Gwaelod Y Garth
    CF4 8HJ Cardiff
    Geschäftsführer
    Valley View Main Road
    Gwaelod Y Garth
    CF4 8HJ Cardiff
    United KingdomBritish59037720001
    HAWKINS, Christopher Alan
    6 Court Rise
    NP7 9YH Abergavenny
    Sekretär
    6 Court Rise
    NP7 9YH Abergavenny
    British57652130001
    JENKINS, David Edwin
    Blanda
    16 Forge Lane Basaleg
    Newport
    Mid Glamorgan
    Wales
    Sekretär
    Blanda
    16 Forge Lane Basaleg
    Newport
    Mid Glamorgan
    Wales
    British50488410001
    LOCK, Ian Winter
    20 Wick Road
    Ewenny
    CF35 5BL Bridgend
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    20 Wick Road
    Ewenny
    CF35 5BL Bridgend
    Mid Glamorgan
    British8622440001
    LOCK, Ian Winter
    20 Wick Road
    Ewenny
    CF35 5BL Bridgend
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    20 Wick Road
    Ewenny
    CF35 5BL Bridgend
    Mid Glamorgan
    British8622440001
    ROEDEMEER, Stephanie
    Meadows End
    Llangan
    CF35 5DW Bridgend
    Mid Glamorgan
    Sekretär
    Meadows End
    Llangan
    CF35 5DW Bridgend
    Mid Glamorgan
    British8622450001
    SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003990001
    ALLEN, John Robert
    Lime Ridge Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 7SB Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Lime Ridge Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 7SB Bristol
    Avon
    United KingdomBritish15648150002
    GRIFFITHS, Denzil
    4 Craig Yr Haul Drive
    Castleton
    CF3 8SA Cardiff
    Geschäftsführer
    4 Craig Yr Haul Drive
    Castleton
    CF3 8SA Cardiff
    British60879180001
    HAWKINS, Christopher Alan
    6 Court Rise
    NP7 9YH Abergavenny
    Geschäftsführer
    6 Court Rise
    NP7 9YH Abergavenny
    British57652130001
    JENKINS, David Edwin
    Blanda
    16 Forge Lane Basaleg
    Newport
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Blanda
    16 Forge Lane Basaleg
    Newport
    Mid Glamorgan
    Wales
    British50488410001
    LOCK, Ian Winter
    20 Wick Road
    Ewenny
    CF35 5BL Bridgend
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    20 Wick Road
    Ewenny
    CF35 5BL Bridgend
    Mid Glamorgan
    British8622440001
    LOCK, Stephen
    The Orchard
    Coed Y Mwstwr
    CF35 6AF Bridgend
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    The Orchard
    Coed Y Mwstwr
    CF35 6AF Bridgend
    Mid Glamorgan
    WalesBritish8622410001
    NICKLIN, Albert Derry
    Llwyncwtrych
    Glangrwyney
    NP8 1EE Crickhowell
    Powys
    Geschäftsführer
    Llwyncwtrych
    Glangrwyney
    NP8 1EE Crickhowell
    Powys
    WalesBritish35640230001
    ROEDEMEER, Stephanie
    Meadows End
    Llangan
    CF35 5DW Bridgend
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Meadows End
    Llangan
    CF35 5DW Bridgend
    Mid Glamorgan
    British8622450001
    ROEDEMER, Nigel Stuart
    Meadows End
    Llangarn
    Bridgend
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    Meadows End
    Llangarn
    Bridgend
    Mid Glamorgan
    British39691560001
    VAILE, Derek William
    Moorlands Hall
    Penllyn
    CF71 7RQ Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Moorlands Hall
    Penllyn
    CF71 7RQ Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    British60547240001
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    Hat MAINCOURSE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2008
    Geliefert am 04. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Juli 2006
    Geliefert am 04. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at park house court narbeth road tenby pembrokeshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 116. Juni 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 2005
    Geliefert am 27. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a wagonworks danygraig road port tennant swansea t/n WA139764.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Apr. 2005
    Geliefert am 23. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of the building agreement and licence relating to the development of the former dunlop semtex site at brynmawr gwent
    Erstellt am 28. März 2001
    Geliefert am 12. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right,title and interest whatsoever under or arising out of the building agreement dated 13/11/2000 (as defined) with all guarantees,indemnities,bonds and other security thereunder and all licence fee,as defined,and all claims for damages or other remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 17. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as land and buildings lying on the west and east side of blaina road brynmawr; WA790134. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 17. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as land lying to the west of blaina road brynmawr; WA357468. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 17. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 17. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land being land adjoining land and buildings on the west and east side of blaina road brynmawr. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 16. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities from the company to the chargee whether pursuant to or arising from the urban investment grant agreement dated 13TH november 2000 and any further sums howsoever due to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a the former dunlop semtex site and surrounding land situated at brynmawr blaenau gwent - WA790134 and WA357468 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Welsh Development Agency
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Apr. 1996
    Geliefert am 30. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of an option agreement dated 22/4/94 and this legal charge
    Kurze Angaben
    All that f/h land lying on the east and west sides of blaina road brynmawr gwent t/no WA403743 & WA357468 together with the land adjoining the land comprised in t/no wa 403743 with all buildings and fixtures thereon and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • John Williams Industries PLC and the Wyndham Group PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MAINCOURSE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Phillip Roger Poolman
    3 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    South Glamorgan
    Receiver Manager
    3 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    South Glamorgan
    Andrew Jeffrey Hughes
    3 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    South Glamorgan
    Receiver Manager
    3 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    South Glamorgan
    2
    DatumTyp
    11. Juli 2011Beginn der Liquidation
    02. Nov. 2012Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gary Stones
    63 Walter Road
    Swansea
    SA1 4DT
    Praktiker
    63 Walter Road
    Swansea
    SA1 4DT

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0