DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED

DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02874550
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED?

    • (5133) /

    Wo befindet sich DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE MILK GROUP LIMITED23. Juni 199523. Juni 1995
    THE MILK GROUP (NORTH WEST) LIMITED06. Jan. 199406. Jan. 1994
    BECKWOOL LIMITED23. Nov. 199323. Nov. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2011

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 08. Nov. 2011

    11 Seiten2.35B

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    9 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Juni 2011

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Dez. 2010

    6 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Juni 2010

    6 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Dez. 2009

    7 Seiten2.24B

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Vorschlag des Verwalters

    27 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten403b

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten403b

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    5 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BSDR CORPORATE SERVICES LIMITED
    25 Milton Park
    OX14 4SH Abingdon
    Oxfordshire
    Sekretär
    25 Milton Park
    OX14 4SH Abingdon
    Oxfordshire
    94916910002
    GRANTCHESTER, Christopher John, Lord
    Lower House Farm
    Back Coole Lane Audlem
    CW3 0ER Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Lower House Farm
    Back Coole Lane Audlem
    CW3 0ER Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishPeer77121930001
    WILKINSON, David Robert William
    Throstle Nest Farms
    Head Dyke Lane
    PR3 6SD Pilling
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Throstle Nest Farms
    Head Dyke Lane
    PR3 6SD Pilling
    Lancashire
    United KingdomBritishFarmer107709500001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    OXFORD CORPORATE SERVICES LTD
    12 Payton Street
    CV37 6UA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    12 Payton Street
    CV37 6UA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    66596380001
    ARLINGTON, Edward Michael Astley
    Middlethorpe Grange Farm
    Ollerton Road Caunton
    NG23 6BB Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Middlethorpe Grange Farm
    Ollerton Road Caunton
    NG23 6BB Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritishFarmer33206410001
    AUDAS, Robert Graham
    Cherry Blossom
    29 Upton Lane
    CH2 1EB Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Cherry Blossom
    29 Upton Lane
    CH2 1EB Chester
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director103678030001
    COOKSEY, Andrew Thomas
    Overton Edge
    Whitewood Lane
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Overton Edge
    Whitewood Lane
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    EnglandBritishDirector116786610001
    COWARD, Norman
    16 Ibis Lane Chiswick Quay
    W4 3UP London
    Geschäftsführer
    16 Ibis Lane Chiswick Quay
    W4 3UP London
    BritishEx Banker61016690001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FAIR, Richard William
    Chapel House Farm
    Pulford
    CH4 9EW Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Chapel House Farm
    Pulford
    CH4 9EW Chester
    Cheshire
    EnglandBritishFarmer86128520001
    GARRETT, Colin Francis
    Parklands
    GL12 7NR Wotton-Under-Edge
    Janlin 68
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Parklands
    GL12 7NR Wotton-Under-Edge
    Janlin 68
    Gloucestershire
    EnglandBritishFarmer135334900001
    GARVEY, Richard Anthony
    1 Long Street
    Cerne Abbas
    DT2 7JF Dorchester
    Dorset
    Geschäftsführer
    1 Long Street
    Cerne Abbas
    DT2 7JF Dorchester
    Dorset
    BritishMarketing Consultant70625770002
    GITTINS, John Howell
    Hall Farm
    Ruyton Xi Towns
    SY4 1LA Shrewsbury
    Salop
    Geschäftsführer
    Hall Farm
    Ruyton Xi Towns
    SY4 1LA Shrewsbury
    Salop
    United KingdomBritishFarmer8534860001
    KINSEY, John David
    The Moss
    Stapleford
    CW6 0ET Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Moss
    Stapleford
    CW6 0ET Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishFarming37329500001
    KNIGHT, Robert Frederick
    March House
    Thoroton
    NG13 9DS Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    March House
    Thoroton
    NG13 9DS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector48822410001
    MERRY, Anthony Lee
    Elm Tree House The Green
    GU8 4LZ Dunsford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elm Tree House The Green
    GU8 4LZ Dunsford
    Surrey
    BritishManagement Consultant54508310002
    RISLEY, George Francis
    Garden House 1 Church Road
    Egginton
    DE65 6HP Derby
    Geschäftsführer
    Garden House 1 Church Road
    Egginton
    DE65 6HP Derby
    BritishNon Executive30458550003
    SMITH, Malcolm
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritishChief Executive Officer93227360001
    STERN, David Maurice
    Brassey Green Hall
    Tiverton
    CW6 9UG Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Brassey Green Hall
    Tiverton
    CW6 9UG Chester
    Cheshire
    United KingdomBritishCotton Merchant8810540001
    TOLLEMACHE, Timothy John Edward, The Lord
    Helmingham Hall
    IP14 6EF Stowmarket
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Helmingham Hall
    IP14 6EF Stowmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishFarmer Landowner23634340001
    VERITY, Michael William
    Woodend Cottage
    Horsley Lane Beeston
    CW6 9TP Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Woodend Cottage
    Horsley Lane Beeston
    CW6 9TP Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishLand Manager19826420001
    VICKERS, Geoffrey Walter
    Castleside Farm Tattenhall Lane
    Beeston
    CW6 9UA Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Castleside Farm Tattenhall Lane
    Beeston
    CW6 9UA Tarporley
    Cheshire
    BritishCompany Director38186950001
    WARREN, Robert Mcholme
    Abloads Court
    Sandhurst
    GL2 9NG Gloucester
    Geschäftsführer
    Abloads Court
    Sandhurst
    GL2 9NG Gloucester
    BritishFarmer65585010002

    Hat DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 15. Juli 2008
    Geliefert am 19. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 19. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 29. Juli 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 10. Aug. 2004
    Geliefert am 25. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Co-Operative Group (Cws) Limited
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Aug. 2004
    Geliefert am 25. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC ( as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 23. Sept. 2003
    Geliefert am 03. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being strip of land at fengate peterborough. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Jan. 2001
    Geliefert am 26. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at the junction of fengate and third drove peterborough t/n CB216405. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 29. Nov. 2000
    Geliefert am 01. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement.account number 0061676.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2000
    Geliefert am 23. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Sept. 1999
    Geliefert am 17. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at the junction of fengate and third drove peterborough t/n CB216405 goodwill of the business and benefit of the licenses.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 17. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on book debts
    Erstellt am 15. Apr. 1998
    Geliefert am 21. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book debts both present and future and the proceeds thereof and the benefit of all rights relating thereto for full details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DAIRY FARMERS OF BRITAIN PROCESSING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Nov. 2011Ende der Verwaltung
    04. Juni 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Mark Oldfield
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    David James Kelly
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praktiker
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0