SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP
Überblick
| Unternehmensname | SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 02883758 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Kingdom Street W2 6BD London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP LIMITED | 25. Nov. 2005 | 25. Nov. 2005 |
| SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP PLC | 13. Dez. 1994 | 13. Dez. 1994 |
| BARNHILL PLC | 01. Jan. 1994 | 01. Jan. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Takeda Corporate Services Limited als Sekretär am 31. Mai 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Clark Neal als Geschäftsführer am 18. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Gibbons als Geschäftsführer am 08. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Ms Seyda Atadan Memis als Direktor am 01. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Peter Michael Grubin als Direktor am 01. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kentaro Shirahata als Geschäftsführer am 01. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 37 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Mark Gibbons als Direktor am 30. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Hugh Meryon Insall als Geschäftsführer am 30. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Shire Corporate Services Limited am 28. Apr. 2020 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2019 bis 31. März 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Clark Neal am 06. Feb. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 33 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Damien Rodolphe Edmond Bailly als Geschäftsführer am 06. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Ausgabe einer neuen Aktienklasse durch eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung | 3 Seiten | SH09 | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Clark Neal als Direktor am 12. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBIN, Peter Michael | Geschäftsführer | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | American | 293835890001 | |||||||||
| MEMIS, Seyda Atadan | Geschäftsführer | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | Turkish | 299191490001 | |||||||||
| GUTHRIE, Anthony James | Sekretär | Hampshire Int Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Lime Tree Way Hampshire | British | 131668010002 | ||||||||||
| HARRIS, Neil Charles | Sekretär | Old Tiles Church Lane SP6 3LE Martin Hampshire | British | 96188470001 | ||||||||||
| MAY, Tatjana Anni Hilde | Sekretär | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | British | 75855670003 | ||||||||||
| MCLEAN, Andrew Firth | Sekretär | Beech Cottage London Road RG27 8RN Hartley Wintney Hampshire | British | 55993260003 | ||||||||||
| RUSSSELL, Angus Charles | Sekretär | High View Monks Well GU10 1RH Farnham Surrey | British | 75381100001 | ||||||||||
| STRAWBRIDGE, Oliver | Sekretär | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | 202187490001 | |||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| TAKEDA CORPORATE SERVICES LIMITED | Sekretär | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom |
| 244206590002 | ||||||||||
| BAILLY, Damien Rodolphe Edmond | Geschäftsführer | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | France | French | 242039150001 | |||||||||
| BELLINI, Francesco, Dr | Geschäftsführer | 307 Rue Portland H3R 1V4 Ville Mont Royal Quebec Canada | Canadian | 76159220001 | ||||||||||
| BOWLING, James Nicholas | Geschäftsführer | Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire International Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 178036960001 | |||||||||
| BOWLING, James Nicholas | Geschäftsführer | Hampshire International Busines Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 178036960001 | |||||||||
| BRANSGROVE, Roderick Granville | Geschäftsführer | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 | United Kingdom | British | 48749520001 | |||||||||
| BUCHANAN, Robin William Turnbull | Geschäftsführer | Shire Plc Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | British | 25905100002 | ||||||||||
| CANAVAN, Bernard | Geschäftsführer | 19700 Beach Road Apartment 2 North Jupiter Island Florida Usa 33469 | American | 63249680001 | ||||||||||
| CARRUTHERS, Fearghas Macgilp Kerr | Geschäftsführer | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 178667180002 | |||||||||
| CAVANAUGH, James Henry, Doctor | Geschäftsführer | Shire Plc Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | American | 52100100002 | ||||||||||
| CHARLTON, Peter John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||||||
| CLEMENTS, Patrick Norris | Geschäftsführer | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 122369120001 | |||||||||
| CLEMENTS, Patrick Norris | Geschäftsführer | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 122369120001 | |||||||||
| EMMENS, Matthew William | Geschäftsführer | Hampshire International Business Park Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | American | 88969740002 | ||||||||||
| GARVEY, James | Geschäftsführer | One Beacon Street Boston FOREIGN Usa 02108 | American | 43825460001 | ||||||||||
| GIBBONS, Mark | Geschäftsführer | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | England | South African | 248159240001 | |||||||||
| GRANT, James Andrews, Honorable Pc | Geschäftsführer | Shire Plc Hampshire International Business Park RG24 8EP Chineham Basingstoke | Canadian | 76159160001 | ||||||||||
| GRIGGS, Roger | Geschäftsführer | 7900 Tanners Gate Dr Suite 200 KY 41042 Florence Kentucky Usa | American | 55196760001 | ||||||||||
| HARTLEY, Daniel William David | Geschäftsführer | Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire International Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 184526870001 | |||||||||
| HARTLEY, Daniel William David | Geschäftsführer | Hampshire International Business Park RG24 8EP Basingstoke Hampshire | United Kingdom | Australian | 184526870001 | |||||||||
| HETHERINGTON, Graham Charles | Geschäftsführer | Lime Tree Way Hampshire Int Business Park, Chineham RG24 8EP Basingstoke . Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 132396390001 | |||||||||
| HOROVITZ, Zola, Doctor | Geschäftsführer | 6110 N.W. 42nd Way Boca Raton 33496 Florida Usa | American | 67993590001 | ||||||||||
| INSALL, Nicholas Hugh Meryon | Geschäftsführer | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 248118390001 | |||||||||
| KAPPLER, David John | Geschäftsführer | Hampshire International Business Park Chineham RG24 3EP Basingstoke Shire Plc Hampshire | England | British | 137007730001 | |||||||||
| LANGLOIS, Patrick Jean Marie | Geschäftsführer | Shire Plc, Hampshire International Business Park, Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire | French | 109662720001 | ||||||||||
| MARTEL, Timothy John | Geschäftsführer | Chineham RG24 8EP Basingstoke Hampshire International Business Park Hampshire United Kingdom | United Kingdom | English | 162356650001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shire Biopharmaceuticals Holdings | 06. Apr. 2016 | Kingdom Street W2 6BD London 1 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 1999 Geliefert am 06. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations (monetary or otherwise ) of the company to the chargee arising under or in connection with the amended and restated credit agreement dated 19TH november 1999, any interest rate swap,cap,collar or similar agreement entered into pursuant to the terms of the credit agreement, any promissory note payable to any lender under the credit agreement evidencing the agrregate indebtedness to any such lender ,any standby or commercial letters of credit any loan request any letter of credit request,the letter dated 19TH november 199 and any agreements defined therein | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 1994 Geliefert am 05. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from shire pharmaceutical development limited to the noteholders (as defined) in respect of the £10,000,000 10% fixed rate secured loan notes of 1995 of spdl originally constituted by the deed poll of spdl dated 1994 or under the terms of the loan note instrument and all reasonable costs,charges and expenses incurred under or in respect of the debenture by the instructing group (as defined) or by the noteholders or by any receiver appointed under the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0