WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02884087 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | St Ann'S Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SCOTSMAN BEVERAGE SYSTEMS LIMITED | 29. Juni 1999 | 29. Juni 1999 |
| SCOTSMAN DRINK LIMITED | 02. Feb. 1994 | 02. Feb. 1994 |
| CITYMEET PROJECTS LIMITED | 04. Jan. 1994 | 04. Jan. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 16. Juni 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Kachmer als Geschäftsführer am 03. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Graham Philip Brisley Veal als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Blades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maurice Delon Jones am 04. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Prima Secretary Limited am 04. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Doerr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Sekretär | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Geschäftsführer | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Geschäftsführer | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Geschäftsführer | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Sekretär | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Sekretär | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| NIMMO, James Alexander | Sekretär | 49 Tremadol Road SW4 7NA London | British | 67637800001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Sekretär | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Geschäftsführer | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| COOK, Graham Frederick | Geschäftsführer | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| DE ST PAER, Michael John | Geschäftsführer | Highway Farm Great Staughton PE19 5BG St. Neots Cambridgeshire | British | 77760720002 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Geschäftsführer | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| EDGE, Andrew John | Geschäftsführer | 4 Southfields Court Albert Drive SW19 6LJ London | British | 66573870001 | ||||||||||
| HOLMES, Don | Geschäftsführer | 775 Corporate Woods Parkway 60061 Vernon Hills Lake Illinois Usa | Us | 48648200001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Geschäftsführer | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| KACHMER, Michael James | Geschäftsführer | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| LEE, Richard John | Geschäftsführer | The Gables Ledbury Road, Eastnor HR8 1EL Ledbury Herefordshire | British | 79012830002 | ||||||||||
| NIMMO, James Alexander | Geschäftsführer | 49 Tremadol Road SW4 7NA London | British | 67637800001 | ||||||||||
| OSBORNE, Richard Cogswell | Geschäftsführer | 465 Dundee Road 60022 Glencoe Illinois Usa | Us Citizen | 48648260001 | ||||||||||
| RUSHTON, John | Geschäftsführer | Meadowcroft The Paddock Pedmore DY9 0RE Stourbridge West Midlands | British | 57521970001 | ||||||||||
| SPENCER, Peter David | Geschäftsführer | The White House Broome Lane Blakedown DY10 3LP Kidderminster Worcestershire | British | 78077650001 | ||||||||||
| BERSIFORD (OVERSEAS) LIMITED | Geschäftsführer | Theplace 175 High Holborn W1V 7AA London | 71006040002 | |||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Geschäftsführer | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
Hat WHITLENGE DRINK EQUIPMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Erstellt am 11. Apr. 2002 Geliefert am 25. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Erstellt am 20. Feb. 2002 Geliefert am 08. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 12. März 1997 Geliefert am 27. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The obligations (being all unpaid principal of and accrued and unpaid interest on the notes,the facility letter of credit obligations(both as defined in the agreement) and all other liabilities (if any) of scotsman group inc.,the delfield company,the company,whitlenge drink equipment limited,frimont S.P.A.,castel mac S.P.A.,kysor industrial corporation and any other company admitted as a borrower pursuant to the agreement to any of the first national bank of chicago and its successors and permitted assigns arising under any of the loan documents and any rate hedging obligations (both as defined in the agreement) or foreign exchange contracts of the borrowers owing to any lender). | |
Kurze Angaben Any and all deposits and any other indebtedness (as defined in the agreement) at any time held or owing by any lender to or for the credit or account of any borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0