IOP 02886867 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIOP 02886867 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02886867
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IOP 02886867 LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich IOP 02886867 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IOP 02886867 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PEER FREEHOLDS LIMITED12. Jan. 199412. Jan. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IOP 02886867 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für IOP 02886867 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Beendigung der Bestellung von Martin Brendan Birrane als Geschäftsführer am 09. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Cessation of Martin Brendan Birrane as a person with significant control on 09. Juni 2018

    1 SeitenPSC07

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Howard Dawson am 24. Jan. 2018

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Peer Suite the Hop Exchange 24 Southwark Street London SE1 1TY zum Two Snowhill Birmingham B4 4GA am 22. Mai 2017

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Apr. 2017

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name27. Okt. 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 13. Okt. 2016

    RES15

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2015

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 15. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028868670010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028868670011 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 1

    2 SeitenMR05

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    2 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von IOP 02886867 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BREEZE, Michael David
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Sekretär
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    181173070001
    BIRRANE, Susan Alice
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Geschäftsführer
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    GibraltarBritish7828640008
    BIRRANE-RULE, Amanda
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Geschäftsführer
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    United KingdomBritish67689710002
    BREEZE, Michael David
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Geschäftsführer
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    EnglandBritish184073430001
    DAWSON, Howard James
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Geschäftsführer
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    EnglandBritish152733740001
    MANDER, Richard Charles
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Geschäftsführer
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    United KingdomBritish55797010002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Sekretär
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    British7736140001
    WALLWORK, Paul Antony Hewitt
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Sekretär
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    174564620001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BIRRANE, Bridget Kathleen
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    Geschäftsführer
    The Peer Suite
    The Hop Exchange
    SE1 1TY 24 Southwark Street
    London
    EnglandBritish91838040001
    BIRRANE, Martin Brendan
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Geschäftsführer
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    GibraltarIrish7736150006
    COUCHMAN, Robert Wilfred
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    20 Rectory Park
    Sanderstead
    CR2 9JN South Croydon
    Surrey
    EnglandBritish159317370002
    SMITH, Peter James
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    Geschäftsführer
    5 Maryland Court
    Rainham
    ME8 8QY Gillingham
    Kent
    United KingdomBritish7736140001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei IOP 02886867 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Martin Brendan Birrane
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    06. Apr. 2016
    Two Snowhill
    B4 4GA Birmingham
    Ja
    Nationalität: Irish
    Staatsangehörigkeit: Gibraltar
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Peer Group Plc
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    The Hop Exchange
    24 Southwark Street
    SE1 1TY London
    The Peer Suite
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer1265425
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat IOP 02886867 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. Apr. 2015
    Geliefert am 29. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 23. Okt. 2013
    Geliefert am 06. Nov. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The freehold land known as saxon house, sunbury, surrey (registered as SY432619). The freehold land known as centurion house, crewe gates farm industrial estate, crewe, cheshire (registered as CH393677), the freehold land known as paternoster house, brunel way, thetford, norfolk (NK174417) and all properties set out in security previously given by the company in favour of the chargee.
    Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 23. Okt. 2012
    Geliefert am 30. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and peer freeholds (newcastle) limited to the fiance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Pfandbriefbank Ag as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 10. Juni 2004
    Geliefert am 16. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The new property being all the f/h land and buildings k/a 34-40 windsor house, high street, esher t/no SY692349 all gross rental income as such relates to the new property; all guarantees now or in the future of all gross rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hypo Real Estate Bank International, London Branch (The Successor Agent)
    Transaktionen
    • 16. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30 march 2000)
    Erstellt am 28. Okt. 2002
    Geliefert am 02. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Freehold land 35, 37, 39, 41, 43, 45 and 47 high street and 2, 4, 6, 8 and 10 cromwell road redhill t/n SY475297. By way of assignment all gross rental income, all guarantees now or in the future of all gross rental income, all agreements, policies of insurance and warranties. By way of fixed charge the benefit of all rights and claims, all guarantees, warranties and representations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The Facilty Agent)
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Third party charge over shares
    Erstellt am 23. Aug. 2001
    Geliefert am 01. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to each finance document and of the company to each finance party under or pursuant to the charge over shares
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the securities bring all stocks shares bonds and securities of any kind (marketable or otherwise) negotiable instruments and and warrants beneficially owned by the company comprised within the borrower and all interest dividends rights and benefits arising therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The "Facility Agent")as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 18. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that the property k/a middle entry shopping centre tamworth t/n SF170234 property conveyed by a conveyance dated 25/03/1970 the "new properties" all gross rental income,all guarantees,all agreements policies of insurance and warranties please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hvb Real Estate Capital Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 2000
    Geliefert am 11. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hvb Real Estate Capital Limited (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 made between the company and the bank)
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all estates or interests in mace industrial estate ashford kent t/nos.K253827 and K307368 and unit 10 maesglas retail park newport road newport gwent t/no.WA164510. By way of assignment all gross rental income and all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft (The Bank)
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 and issued by the company
    Erstellt am 18. Nov. 1996
    Geliefert am 26. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all estates or interest in the new properties being l/h-land known as pemberton house stafford court telford shropshire t/n-SL90860. F/h-land known as st martin's house hatfield hertfordshire t/n-HD244828. F/h-land known as saxon house sunbury surrey t/n-SY432619. (For the other 4 properties charged see ch microfiche). By way of assignment: all gross rental income insofar as such relates to the new properties and the rights of the company to receive the same;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Weschel-Bank Aktiengessellschaft
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 1996
    Geliefert am 07. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness obligations and liabilities due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken -Und Weschel -Bank Akteingesselshaft
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2015Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 29. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat IOP 02886867 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Apr. 2017Beginn der Liquidation
    09. Nov. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Malcolm Cohen
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0