IOP 02886867 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | IOP 02886867 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02886867 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IOP 02886867 LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich IOP 02886867 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Two Snowhill B4 4GA Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von IOP 02886867 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PEER FREEHOLDS LIMITED | 12. Jan. 1994 | 12. Jan. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IOP 02886867 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IOP 02886867 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Brendan Birrane als Geschäftsführer am 09. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Cessation of Martin Brendan Birrane as a person with significant control on 09. Juni 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Howard Dawson am 24. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Peer Suite the Hop Exchange 24 Southwark Street London SE1 1TY zum Two Snowhill Birmingham B4 4GA am 22. Mai 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2015 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 028868670010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 028868670011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 1 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von IOP 02886867 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREEZE, Michael David | Sekretär | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | 181173070001 | |||||||
| BIRRANE, Susan Alice | Geschäftsführer | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | Gibraltar | British | 7828640008 | |||||
| BIRRANE-RULE, Amanda | Geschäftsführer | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | United Kingdom | British | 67689710002 | |||||
| BREEZE, Michael David | Geschäftsführer | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | England | British | 184073430001 | |||||
| DAWSON, Howard James | Geschäftsführer | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | England | British | 152733740001 | |||||
| MANDER, Richard Charles | Geschäftsführer | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | United Kingdom | British | 55797010002 | |||||
| SMITH, Peter James | Sekretär | 5 Maryland Court Rainham ME8 8QY Gillingham Kent | British | 7736140001 | ||||||
| WALLWORK, Paul Antony Hewitt | Sekretär | The Peer Suite The Hop Exchange SE1 1TY 24 Southwark Street London | 174564620001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BIRRANE, Bridget Kathleen | Geschäftsführer | The Peer Suite The Hop Exchange SE1 1TY 24 Southwark Street London | England | British | 91838040001 | |||||
| BIRRANE, Martin Brendan | Geschäftsführer | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | Gibraltar | Irish | 7736150006 | |||||
| COUCHMAN, Robert Wilfred | Geschäftsführer | 20 Rectory Park Sanderstead CR2 9JN South Croydon Surrey | England | British | 159317370002 | |||||
| SMITH, Peter James | Geschäftsführer | 5 Maryland Court Rainham ME8 8QY Gillingham Kent | United Kingdom | British | 7736140001 | |||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei IOP 02886867 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Martin Brendan Birrane | 06. Apr. 2016 | Two Snowhill B4 4GA Birmingham | Ja | ||||||||||
Nationalität: Irish Staatsangehörigkeit: Gibraltar | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Peer Group Plc | 06. Apr. 2016 | The Hop Exchange 24 Southwark Street SE1 1TY London The Peer Suite United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat IOP 02886867 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 21. Apr. 2015 Geliefert am 29. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 23. Okt. 2013 Geliefert am 06. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The freehold land known as saxon house, sunbury, surrey (registered as SY432619). The freehold land known as centurion house, crewe gates farm industrial estate, crewe, cheshire (registered as CH393677), the freehold land known as paternoster house, brunel way, thetford, norfolk (NK174417) and all properties set out in security previously given by the company in favour of the chargee. Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 23. Okt. 2012 Geliefert am 30. Okt. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and peer freeholds (newcastle) limited to the fiance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 10. Juni 2004 Geliefert am 16. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The new property being all the f/h land and buildings k/a 34-40 windsor house, high street, esher t/no SY692349 all gross rental income as such relates to the new property; all guarantees now or in the future of all gross rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30 march 2000) | Erstellt am 28. Okt. 2002 Geliefert am 02. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Freehold land 35, 37, 39, 41, 43, 45 and 47 high street and 2, 4, 6, 8 and 10 cromwell road redhill t/n SY475297. By way of assignment all gross rental income, all guarantees now or in the future of all gross rental income, all agreements, policies of insurance and warranties. By way of fixed charge the benefit of all rights and claims, all guarantees, warranties and representations. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party charge over shares | Erstellt am 23. Aug. 2001 Geliefert am 01. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to each finance document and of the company to each finance party under or pursuant to the charge over shares | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the securities bring all stocks shares bonds and securities of any kind (marketable or otherwise) negotiable instruments and and warrants beneficially owned by the company comprised within the borrower and all interest dividends rights and benefits arising therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 11. Juli 2000 Geliefert am 18. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that the property k/a middle entry shopping centre tamworth t/n SF170234 property conveyed by a conveyance dated 25/03/1970 the "new properties" all gross rental income,all guarantees,all agreements policies of insurance and warranties please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 2000 Geliefert am 11. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture (supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 made between the company and the bank) | Erstellt am 01. Mai 1997 Geliefert am 07. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in mace industrial estate ashford kent t/nos.K253827 and K307368 and unit 10 maesglas retail park newport road newport gwent t/no.WA164510. By way of assignment all gross rental income and all guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 30TH july 1996 and issued by the company | Erstellt am 18. Nov. 1996 Geliefert am 26. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interest in the new properties being l/h-land known as pemberton house stafford court telford shropshire t/n-SL90860. F/h-land known as st martin's house hatfield hertfordshire t/n-HD244828. F/h-land known as saxon house sunbury surrey t/n-SY432619. (For the other 4 properties charged see ch microfiche). By way of assignment: all gross rental income insofar as such relates to the new properties and the rights of the company to receive the same;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 1996 Geliefert am 07. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness obligations and liabilities due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat IOP 02886867 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0