AERO INVENTORY PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAERO INVENTORY PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02887038
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AERO INVENTORY PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich AERO INVENTORY PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AERO INVENTORY PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HIBBERT & RICHARDS HOLDINGS LIMITED16. Juni 199416. Juni 1994
    LAW 565 LIMITED12. Jan. 199412. Jan. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AERO INVENTORY PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für AERO INVENTORY PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    28 SeitenAM10

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    28 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2017

    26 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    2 Seiten2.31B

    Kündigung eines Administrators

    1 Seiten2.38B

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:order of court in respect of replacement liquidators
    30 SeitenLIQ MISC OC

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Aug. 2016

    26 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2016

    25 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Aug. 2015

    26 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL am 08. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2015

    26 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Aug. 2014

    26 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    26 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Mai 2014

    27 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Nov. 2013

    39 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Martin Webster als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Martin Webster als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Collin Trupp als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Mai 2013

    41 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Nov. 2012

    39 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Nov. 2012

    39 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Wer sind die Geschäftsführer von AERO INVENTORY PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIS, Roger William John
    C/O Aero Inventory, 30
    Lancaster Road
    EN4 8AP Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    C/O Aero Inventory, 30
    Lancaster Road
    EN4 8AP Barnet
    Hertfordshire
    BritishDirector118966450001
    DODGE, Martin Peter
    2a Rothsay Gardens
    MK40 3QB Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    2a Rothsay Gardens
    MK40 3QB Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector38506480006
    HEYWORTH, Laurence
    3 York House
    Upper Montagu Street
    W1H 1FR London
    Geschäftsführer
    3 York House
    Upper Montagu Street
    W1H 1FR London
    United KingdomBritishDirector68749830002
    LEWIN, Paul Rupert
    163e Porchester Terrace North
    W2 6BJ London
    Geschäftsführer
    163e Porchester Terrace North
    W2 6BJ London
    EnglandBritishDirector34103040001
    MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    Geschäftsführer
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    EnglandEnglishCompany Director13447260001
    TURNER, Frank
    Tamarind 46 Main Street
    Kings Newton
    DE73 8BX Melbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Tamarind 46 Main Street
    Kings Newton
    DE73 8BX Melbourne
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director47893720001
    BEVAN, Hugh Charles
    Manor House
    Church Road, Upper Farringdon
    GU34 3EG Alton
    Hampshire
    Sekretär
    Manor House
    Church Road, Upper Farringdon
    GU34 3EG Alton
    Hampshire
    BritishCompany Director81600350001
    NATHAN, Stuart Michael
    71 Lincoln Road
    EN1 1JU Enfield
    Middlesex
    Sekretär
    71 Lincoln Road
    EN1 1JU Enfield
    Middlesex
    BritishAccountant36851350001
    RICHARDSON, Peter Edward
    30 Oaklands Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7UJ Hatfield
    Hertfordshire
    Sekretär
    30 Oaklands Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7UJ Hatfield
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary32938470001
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6PE London
    42
    Sekretär
    Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6PE London
    42
    British6916040002
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001
    BEVAN, Hugh Charles
    Manor House
    Church Road, Upper Farringdon
    GU34 3EG Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Manor House
    Church Road, Upper Farringdon
    GU34 3EG Alton
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director81600350001
    DAVEY, Timothy Charles Nicholas
    7 Hales Meadow
    AL5 4JB Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    7 Hales Meadow
    AL5 4JB Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishIt Director49689490004
    DOCKER, Paul Martin
    2 Oast Cottages
    Kake Street Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    2 Oast Cottages
    Kake Street Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    United KingdomBritishDirector154440510001
    HEYWORTH, Laurence
    3 York House
    Upper Montagu Street
    W1H 1FR London
    Geschäftsführer
    3 York House
    Upper Montagu Street
    W1H 1FR London
    United KingdomBritishCompany Director68749830002
    NATHAN, Stuart Michael
    71 Lincoln Road
    EN1 1JU Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    71 Lincoln Road
    EN1 1JU Enfield
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant36851350001
    TRUPP, Collin Lee
    17 Harrow Street
    2224 Sylvania
    Nsw
    Australia
    Geschäftsführer
    17 Harrow Street
    2224 Sylvania
    Nsw
    Australia
    CanadianAustralasia Director104615450003
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6PE London
    42
    Geschäftsführer
    Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6PE London
    42
    EnglandBritishDirector6916040002
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    Hat AERO INVENTORY PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 15. Feb. 2008
    Geliefert am 15. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All tangible and intangible personal property, including but not limited to all accounts, chattel paper, deposit accounts, documents, general intangibles, goods, equipment and related fixtures and attachments and proceeds of the above collateral see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Feb. 2008
    Geliefert am 15. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any revolving facility finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited, as Security Trustee for the Benefit of the Revolving Facility Finance Parties
    Transaktionen
    • 15. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Feb. 2008
    Geliefert am 15. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any revolving facility finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All real property, being the f/h and l/h property in hong kong and fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited, as Security Trustee for the Benefit of the Revolving Facility Finance Parties
    Transaktionen
    • 15. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Feb. 2008
    Geliefert am 22. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each chargor to the chargee and any revolving facility finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2007
    Geliefert am 17. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Agent)
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 05. Okt. 2006
    Geliefert am 18. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. März 2004
    Geliefert am 18. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Juli 2001
    Geliefert am 03. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Aug. 2000
    Geliefert am 13. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or hibbert & richards limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AERO INVENTORY PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Nov. 2009Beginn der Verwaltung
    08. Aug. 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Heis
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    James Robert Tucker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0