AQUADUCKS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AQUADUCKS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02889713 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AQUADUCKS LIMITED?
- Kanalisation (37000) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
Wo befindet sich AQUADUCKS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Dickens House Old Stowmarket Road Woolpit IP30 9QS Bury St. Edmunds Suffolk |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AQUADUCKS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AQUADUCKS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für AQUADUCKS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Calvert als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Harcourt als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Calvert als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Whiskerd als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Christopher Stewart als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Clarfield als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Max William Simon Ashton als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Christopher Stewart als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 80 Station Parade Harrogate North Yorkshire HG1 1HQ* am 16. Sept. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AQUADUCKS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Christopher | Sekretär | Old Stowmarket Road Woolpit IP30 9QS Bury St Edmunds Dickens House Suffolk Uk | British | 154343740001 | ||||||
| ASHTON, Max William Simon | Geschäftsführer | Old Stowmarket Road Woolpit IP30 9QS Bury St Edmunds Dickens House Suffolk Uk | United Kingdom | British | 73381460001 | |||||
| CLARFIELD, Andrew | Geschäftsführer | Old Stowmarket Road Woolpit IP30 9QS Bury St Edmunds Dickens House Suffolk Uk | United Kingdom | British | 139044820001 | |||||
| STEWART, Christopher | Geschäftsführer | Old Stowmarket Road Woolpit IP30 9QS Bury St. Edmunds Dickens House Suffolk Uk | England | British | 153413490001 | |||||
| CALVERT, Hazel Anne | Sekretär | Quantum 73 Sheering Road CM17 0JN Old Harlow Essex | British | 86884430001 | ||||||
| CALVERT, Mark Richard, Mr. | Sekretär | High Bond End HG5 9BT Knaresborough Kirkman Bank North Yorkshire | British | 44425360003 | ||||||
| CALVERT, Mark Richard | Sekretär | Foxwood House 64 Kent Road HG1 2NL Harrogate North Yorkshire | British | 44425360002 | ||||||
| COOPER, Joan Kyle | Sekretär | Micawber House White Elm Road Woolpit IP30 9SQ Bury St Edmunds Suffolk | British | 10015030001 | ||||||
| SZCZEPANSKI, Jan | Sekretär | 16 Durkar Rise Crigglestone WF4 3QB Wakefield West Yorkshire | British | 10925740001 | ||||||
| WILTON, David Charles | Sekretär | 27 Kent Road HG1 2LJ Harrogate North Yorkshire | British | 99414270001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CALVERT, Hazel Anne | Geschäftsführer | Quantum 73 Sheering Road CM17 0JN Old Harlow Essex | British | 86884430001 | ||||||
| CALVERT, Mark Richard, Mr. | Geschäftsführer | High Bond End HG5 9BT Knaresborough Kirkman Bank North Yorkshire | United Kingdom | British | 44425360003 | |||||
| COOPER, Joan Kyle | Geschäftsführer | Micawber House White Elm Road Woolpit IP30 9SQ Bury St Edmunds Suffolk | British | 10015030001 | ||||||
| COOPER, Kenneth Owen | Geschäftsführer | Micawber House White Elm Road Woolpit IP30 9SQ Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 10015040001 | |||||
| HARCOURT, Peter James Rolston | Geschäftsführer | The Garth North Rigton LS17 0DJ Leeds North Yorkshire | England | British | 72476310002 | |||||
| PIRRIE, Michael | Geschäftsführer | Bosmere Cottage Duke Street Haughley IP14 3QS Stowmarket Suffolk | England | British | 124359150001 | |||||
| SZCZEPANSKI, Jan | Geschäftsführer | 16 Durkar Rise Crigglestone WF4 3QB Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 10925740001 | |||||
| WHISKERD, David Austen | Geschäftsführer | 121 Moffats Lane AL9 7RP Hatfield Hertfordshire | England | British | 103890940001 | |||||
| WILTON, David Charles | Geschäftsführer | 27 Kent Road HG1 2LJ Harrogate North Yorkshire | England | British | 99414270001 |
Hat AQUADUCKS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 09. Sept. 2010 Geliefert am 15. Sept. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligor to centric on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Jan. 2003 Geliefert am 21. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Jan. 2003 Geliefert am 21. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0