1458 BIG AM LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 1458 BIG AM LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02890732 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 1458 BIG AM LIMITED?
- (9220) /
Wo befindet sich 1458 BIG AM LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 18 Hatfields London SE1 8DJ |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 1458 BIG AM LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| 1458 LITE AM LIMITED | 30. Sept. 1996 | 30. Sept. 1996 |
| FORTUNE 1458 LIMITED | 24. Jan. 1994 | 24. Jan. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 1458 BIG AM LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 1458 BIG AM LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 8 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 9 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 10 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 12 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
legacy | Seiten | 363(353) | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002 | 14 Seiten | AA | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
Wer sind die Geschäftsführer von 1458 BIG AM LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWNEY, James Robinson | Sekretär | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | 107097580001 | ||||||
| DOWNEY, James Robinson | Geschäftsführer | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | United Kingdom | British | 107097580001 | |||||
| MCCANN, John | Geschäftsführer | 175 Malone Road BT9 6TB Belfast County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | 75447990001 | |||||
| TAUNTON, Scott William | Geschäftsführer | Oak Bank 30 High Street WA12 9SN Newton-Le-Willows Merseyside | England | Australian | 80505610002 | |||||
| ALLEN, Stephen | Sekretär | 1 Avenue Cottages High Street Mill Hill NW7 1QY London | British | 68299700001 | ||||||
| ASHTON, Keir | Sekretär | Top Flat 82 Brondesbury Road NW6 6RX London | British | 68400270001 | ||||||
| DEWHURST, Anthony John | Sekretär | 5 Brentwood Road Anderton PR6 9PL Chorley Lancashire | British | 3275560001 | ||||||
| HEDGES, Gerald Michael | Sekretär | 64 Patricks Copse Road GU33 7DW Liss Hampshire | British | 3309540001 | ||||||
| MASKREY, Steven | Sekretär | The Hayloft Stamford Lane Cotton Edmunds CH3 7QD Chester Cheshire | British | 26059760001 | ||||||
| SADLER, Keith John | Sekretär | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BRISAC, Martin | Geschäftsführer | 26 Bisrue Francais Premier Paris 75008 FOREIGN France | French | 40898280002 | ||||||
| CONNOLLY, Michael Joseph | Geschäftsführer | Tower House Woodlands Grove Grimsargh PR2 5LB Preston Lancashire | British | 3275550001 | ||||||
| DEWHURST, Anthony John | Geschäftsführer | 5 Brentwood Road Anderton PR6 9PL Chorley Lancashire | England | British | 3275560001 | |||||
| DOUTHWAITE, Clive Paul | Geschäftsführer | 5 Scott Close NE46 2QB Hexham Northumberland | British | 44165660001 | ||||||
| GOLDSTONE, Anthony Stewart | Geschäftsführer | Flat 2 Merlewood 17 Langham Road WA14 2HT Bowden Cheshire | British | 96421740001 | ||||||
| GOODWIN, Jonathan Philip Pryce | Geschäftsführer | 29 Broadhinton Road SW4 0LT London | British | 68743940001 | ||||||
| HEDGES, Gerald Michael | Geschäftsführer | 64 Patricks Copse Road GU33 7DW Liss Hampshire | British | 3309540001 | ||||||
| HIGHET, David Corkhill | Geschäftsführer | September Cottage Noctorum Lane CH43 9UE Noctorum Wirral | British | 72009730001 | ||||||
| JONES, Neil Henry | Geschäftsführer | Over Hall Flag Lane Bretherton PR5 7AD Preston | British | 62638630002 | ||||||
| LYNES, Hazel Pamela | Geschäftsführer | Gresford Old Hall Llay Road Gresford Wrexham | British | 39410010003 | ||||||
| MACKENZIE, Ashley Calder | Geschäftsführer | 6 Springshaw Close TN13 2QE Sevenoaks Kent | British | 59529980005 | ||||||
| MASKREY, Steven | Geschäftsführer | The Hayloft Stamford Lane Cotton Edmunds CH3 7QD Chester Cheshire | United Kingdom | British | 26059760001 | |||||
| MILBURN, Peter | Geschäftsführer | Flat 16 55 57 Whitworth Street M1 3NT Manchester | British | 67565920002 | ||||||
| PERRY, Peter Sinclair | Geschäftsführer | Dell O Dene Tuckey Grove GU23 6JQ Ripley Surrey | British | 27189360001 | ||||||
| ROSE, Martyn Craig | Geschäftsführer | 7 Trebeck Street W1Y 7RJ London | United Kingdom | British | 75808040009 | |||||
| ROWBOTHAM, Brian William | Geschäftsführer | 46 Alma Road RH2 0DN Reigate Surrey | England | British | 2359760001 | |||||
| SADLER, Keith John | Geschäftsführer | 12 Parrys Grove Stoke Bishop BS9 1TT Bristol Avon | British | 73173100006 | ||||||
| SAMARU, Mark | Geschäftsführer | 6 Beechfield Drive CW10 9QE Middlewich Cheshire | British | 43994680001 | ||||||
| SWINDELLS, Simon John | Geschäftsführer | 24 Chatsworth Road Dore S17 3QH Sheffield Yorkshire | British | 58736040001 | ||||||
| THOMPSON, Gilbert Williamson, Sir | Geschäftsführer | Longridge 29 Hilltop Hale WA15 0NN Altrincham Cheshire | British | 12746000001 | ||||||
| WALTERS, Colin St John | Geschäftsführer | Old Rectory Bentley GU10 5HU Farnham Surrey | British | 19582030001 | ||||||
| WYNNE, Simon Robert | Geschäftsführer | 2 Dalby Close Birchwood WA3 6TD Warrington Cheshire | British | 51502940001 | ||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat 1458 BIG AM LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Apr. 2000 Geliefert am 10. Mai 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 1998 Geliefert am 30. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0