1458 BIG AM LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname1458 BIG AM LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02890732
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 1458 BIG AM LIMITED?

    • (9220) /

    Wo befindet sich 1458 BIG AM LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    18 Hatfields
    London
    SE1 8DJ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 1458 BIG AM LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    1458 LITE AM LIMITED30. Sept. 199630. Sept. 1996
    FORTUNE 1458 LIMITED24. Jan. 199424. Jan. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 1458 BIG AM LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für 1458 BIG AM LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    9 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    10 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    12 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(353)

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002

    14 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von 1458 BIG AM LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Sekretär
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    British107097580001
    DOWNEY, James Robinson
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    33 Karrington Heights
    Comber Road Dundonald
    BT16 1XZ Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    United KingdomBritish107097580001
    MCCANN, John
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    175 Malone Road
    BT9 6TB Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish75447990001
    TAUNTON, Scott William
    Oak Bank
    30 High Street
    WA12 9SN Newton-Le-Willows
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Oak Bank
    30 High Street
    WA12 9SN Newton-Le-Willows
    Merseyside
    EnglandAustralian80505610002
    ALLEN, Stephen
    1 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill
    NW7 1QY London
    Sekretär
    1 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill
    NW7 1QY London
    British68299700001
    ASHTON, Keir
    Top Flat
    82 Brondesbury Road
    NW6 6RX London
    Sekretär
    Top Flat
    82 Brondesbury Road
    NW6 6RX London
    British68400270001
    DEWHURST, Anthony John
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    British3275560001
    HEDGES, Gerald Michael
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    Sekretär
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    British3309540001
    MASKREY, Steven
    The Hayloft Stamford Lane
    Cotton Edmunds
    CH3 7QD Chester
    Cheshire
    Sekretär
    The Hayloft Stamford Lane
    Cotton Edmunds
    CH3 7QD Chester
    Cheshire
    British26059760001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Sekretär
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    British73173100006
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Sekretär
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BRISAC, Martin
    26 Bisrue Francais
    Premier Paris 75008
    FOREIGN France
    Geschäftsführer
    26 Bisrue Francais
    Premier Paris 75008
    FOREIGN France
    French40898280002
    CONNOLLY, Michael Joseph
    Tower House Woodlands Grove
    Grimsargh
    PR2 5LB Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Tower House Woodlands Grove
    Grimsargh
    PR2 5LB Preston
    Lancashire
    British3275550001
    DEWHURST, Anthony John
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    5 Brentwood Road
    Anderton
    PR6 9PL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish3275560001
    DOUTHWAITE, Clive Paul
    5 Scott Close
    NE46 2QB Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    5 Scott Close
    NE46 2QB Hexham
    Northumberland
    British44165660001
    GOLDSTONE, Anthony Stewart
    Flat 2 Merlewood
    17 Langham Road
    WA14 2HT Bowden
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Flat 2 Merlewood
    17 Langham Road
    WA14 2HT Bowden
    Cheshire
    British96421740001
    GOODWIN, Jonathan Philip Pryce
    29 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    Geschäftsführer
    29 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    British68743940001
    HEDGES, Gerald Michael
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    Geschäftsführer
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    British3309540001
    HIGHET, David Corkhill
    September Cottage
    Noctorum Lane
    CH43 9UE Noctorum
    Wirral
    Geschäftsführer
    September Cottage
    Noctorum Lane
    CH43 9UE Noctorum
    Wirral
    British72009730001
    JONES, Neil Henry
    Over Hall Flag Lane
    Bretherton
    PR5 7AD Preston
    Geschäftsführer
    Over Hall Flag Lane
    Bretherton
    PR5 7AD Preston
    British62638630002
    LYNES, Hazel Pamela
    Gresford Old Hall
    Llay Road
    Gresford
    Wrexham
    Geschäftsführer
    Gresford Old Hall
    Llay Road
    Gresford
    Wrexham
    British39410010003
    MACKENZIE, Ashley Calder
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    6 Springshaw Close
    TN13 2QE Sevenoaks
    Kent
    British59529980005
    MASKREY, Steven
    The Hayloft Stamford Lane
    Cotton Edmunds
    CH3 7QD Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Hayloft Stamford Lane
    Cotton Edmunds
    CH3 7QD Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish26059760001
    MILBURN, Peter
    Flat 16 55 57 Whitworth Street
    M1 3NT Manchester
    Geschäftsführer
    Flat 16 55 57 Whitworth Street
    M1 3NT Manchester
    British67565920002
    PERRY, Peter Sinclair
    Dell O Dene
    Tuckey Grove
    GU23 6JQ Ripley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Dell O Dene
    Tuckey Grove
    GU23 6JQ Ripley
    Surrey
    British27189360001
    ROSE, Martyn Craig
    7 Trebeck Street
    W1Y 7RJ London
    Geschäftsführer
    7 Trebeck Street
    W1Y 7RJ London
    United KingdomBritish75808040009
    ROWBOTHAM, Brian William
    46 Alma Road
    RH2 0DN Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    46 Alma Road
    RH2 0DN Reigate
    Surrey
    EnglandBritish2359760001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    British73173100006
    SAMARU, Mark
    6 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    British43994680001
    SWINDELLS, Simon John
    24 Chatsworth Road
    Dore
    S17 3QH Sheffield
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Chatsworth Road
    Dore
    S17 3QH Sheffield
    Yorkshire
    British58736040001
    THOMPSON, Gilbert Williamson, Sir
    Longridge 29 Hilltop
    Hale
    WA15 0NN Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Longridge 29 Hilltop
    Hale
    WA15 0NN Altrincham
    Cheshire
    British12746000001
    WALTERS, Colin St John
    Old Rectory
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Old Rectory
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    British19582030001
    WYNNE, Simon Robert
    2 Dalby Close
    Birchwood
    WA3 6TD Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    2 Dalby Close
    Birchwood
    WA3 6TD Warrington
    Cheshire
    British51502940001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat 1458 BIG AM LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Apr. 2000
    Geliefert am 10. Mai 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juli 1998
    Geliefert am 30. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0