FIRST LONDON ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FIRST LONDON ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02895536 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIRST LONDON ESTATES LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FIRST LONDON ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FIRST LONDON ESTATES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HITPAY LIMITED | 07. Feb. 1994 | 07. Feb. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIRST LONDON ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIRST LONDON ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Edward Bliss am 01. Jan. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Mr James Neil Thomson als Direktor am 19. Dez. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Andrew Edward Bliss als Direktor am 19. Dez. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr William Patrick Tuffy als Direktor am 19. Dez. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Cessation of First London Holdings Limited as a person with significant control on 07. Apr. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Structadene Limited as a person with significant control on 07. Apr. 2020 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 16 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Alan Pearlman am 18. Juli 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 18 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 17 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Gulam Mohamed Patel als Geschäftsführer am 30. Juni 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 17 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 5 teilweise | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FIRST LONDON ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDBERGER, Michael Robert | Sekretär | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | British | 77295560002 | ||||||
| BLISS, Andrew Edward | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | British | 280457560002 | |||||
| GOLDBERGER, Michael Robert | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 77295560002 | |||||
| PEARLMAN, David Alan | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | British | 35550120026 | |||||
| PEARLMAN, Howard Alan | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | British | 93460740002 | |||||
| THOMSON, James Neil | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | British | 280457680001 | |||||
| TUFFY, William Patrick | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | Irish | 280457620001 | |||||
| COLVIN, Patrick | Sekretär | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | British | 5954030001 | ||||||
| CRICKMORE, Nicola Jane | Sekretär | Brelston Court Barn HR9 6HF Marstow Herefordshire | British | 115328860001 | ||||||
| GOLDBERG, Jonathan David | Sekretär | Queenwood 29 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | British | 33727110001 | ||||||
| CCS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||
| CARLTON PORTER, Robert William | Geschäftsführer | 4 Laggan House College Road BA1 5RY Bath Avon | United Kingdom | British | 67566540006 | |||||
| COLVIN, Patrick | Geschäftsführer | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | England | British | 5954030001 | |||||
| CRICKMORE, Nicola Jane | Geschäftsführer | Brelston Court Barn HR9 6HF Marstow Herefordshire | United Kingdom | British | 115328860001 | |||||
| GADSDEN, Eric John Spencer | Geschäftsführer | Hawridge Place Hawridge HP5 2UG Chesham Buckinghamshire | England | British | 13515270003 | |||||
| GOLDBERG, Jonathan David | Geschäftsführer | Queenwood 29 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | England | British | 33727110001 | |||||
| HARRIS, Howard | Geschäftsführer | 1 Oaklands Road Totteridge N20 8BD London | British | 8500550001 | ||||||
| HARRIS, Jason Mark | Geschäftsführer | 3 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 42831090001 | |||||
| LEWIN, Peter Harry | Geschäftsführer | 1 Wolsey Road Moor Park HA6 2HN Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 2652710001 | |||||
| PATEL, Gulam Mohamed | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | British | 85027050001 | ||||||
| CCS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900001710001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIRST LONDON ESTATES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structadene Limited | 07. Apr. 2020 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| First London Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FIRST LONDON ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. Juni 2012 Geliefert am 19. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 124/130 north promenade and 14 the strand blackpool t/no LA528434 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rectification to debenture dated 9 may 2007 and | Erstellt am 03. Apr. 2008 Geliefert am 22. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Mai 2007 Geliefert am 19. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 124/130 north promenade & 14 the strand blackpool lancashire t/no: LA528434. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Mai 2007 Geliefert am 19. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Apr. 2000 Geliefert am 20. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in accordance with schedule vii of an agreement and all monies due under the terms of the legal charge | |
Kurze Angaben 124, 126 & 130 north promenade and 14 the strand blackpool lancs LA528434 assignment of all monies payable under any insurance on the mortgaged property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 13. Apr. 2000 Geliefert am 20. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 124,126 & 130 north promenade and 14 the strand blackpool.t/no.LA528434.all fixtures and fittings whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached thereto and together with the goodwill of any trade or business carried on now or hereafter at the property by the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. März 1996 Geliefert am 27. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings k/a 124 126 & 130 north promenade and 14 the strand blackpool lancs t/no LA528434 all covenants & rights and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juni 1995 Geliefert am 28. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0