AVONPARK CARE CENTRE LIMITED

AVONPARK CARE CENTRE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAVONPARK CARE CENTRE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02897534
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AVONPARK CARE CENTRE LIMITED?

    • (8511) /

    Wo befindet sich AVONPARK CARE CENTRE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Rivergate Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AVONPARK CARE CENTRE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROADINGTON LIMITED11. Feb. 199411. Feb. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVONPARK CARE CENTRE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für AVONPARK CARE CENTRE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2016

    55 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Sept. 2016

    55 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 26. Sept. 2016

    55 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Feb. 2016

    42 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    7 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2015

    51 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2015

    51 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    55 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2014

    55 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2014

    56 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2013

    66 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2013

    63 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2012

    63 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. März 2012

    78 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Sept. 2011

    74 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Mai 2011

    67 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Derek Purvis als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Shaun Kelly als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Gate House Avonpark Village Winsley Hill Limpley Stoke Bath BA2 7NU* am 24. Jan. 2011

    2 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von AVONPARK CARE CENTRE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURGESS, Anthony John
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    18 Sandford Park Place
    GL52 6HP Cheltenham
    Gloucestershire
    British43144030004
    BURGESS, Anthony John
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    3 Rivergate
    Geschäftsführer
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    3 Rivergate
    EnglandBritish43144030004
    COOPER, Hudson Findlay
    Lakeside
    Chapel Road Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Lakeside
    Chapel Road Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    United KingdomBritish44829380005
    HALL, Sally Janet
    41 Churchill Way
    SN13 0EB Corsham
    Wiltshire
    Sekretär
    41 Churchill Way
    SN13 0EB Corsham
    Wiltshire
    British36750830001
    PURVIS, Derek
    18 Tavinor Drive
    Pewsham
    SN15 3FU Chippenham
    Wiltshire
    Sekretär
    18 Tavinor Drive
    Pewsham
    SN15 3FU Chippenham
    Wiltshire
    British74444890001
    M & N GROUP LIMITED
    2 Duke Street
    SW1Y 6BJ London
    Sekretär
    2 Duke Street
    SW1Y 6BJ London
    74919560004
    M & N SECRETARIES LIMITED
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    Bevollmächtigter Sekretär
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    900001060001
    BURGESS, Anthony John
    12 Regency Gardens
    KT12 2BD Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    12 Regency Gardens
    KT12 2BD Walton On Thames
    Surrey
    British43144030002
    COOPER, James Findlay
    The Gate House
    Avonpark Village
    BA2 7NU Winsley Hill Limpley Stoke
    Bath
    Geschäftsführer
    The Gate House
    Avonpark Village
    BA2 7NU Winsley Hill Limpley Stoke
    Bath
    United KingdomBritish148083700001
    HARPER, Catherine Denise
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Lakeside
    Chapel Road, Hothfield
    TN25 4LN Ashford
    Kent
    British44904500006
    KELLY, Shaun Thomas
    56 The Croft
    Trowbridge
    BA14 0RN Wiltshire
    Geschäftsführer
    56 The Croft
    Trowbridge
    BA14 0RN Wiltshire
    United KingdomBritish122621900001
    CARE ESTATES LIMITED
    The Gatehouse
    Avonpark Village, Limpley Stoke
    BA2 7NU Bath
    Geschäftsführer
    The Gatehouse
    Avonpark Village, Limpley Stoke
    BA2 7NU Bath
    101640660001
    CARE ESTATES LIMITED
    Mountbarrow House
    12 Elizabeth Street
    SW1W 9RB London
    Geschäftsführer
    Mountbarrow House
    12 Elizabeth Street
    SW1W 9RB London
    25376020001
    GUARDHEATH SECURITIES LIMITED
    2 Duke Street
    St James's
    SW1Y 6BJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2 Duke Street
    St James's
    SW1Y 6BJ London
    900001050001

    Hat AVONPARK CARE CENTRE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as land at avonpark care centre winsley road limpley stoke bath BA3 5HF title number WT188007. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 09. Nov. 1999
    Geliefert am 10. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default (as therein defined)
    Kurze Angaben
    The initail deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance as defined on the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 26. Okt. 1999
    Geliefert am 12. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The initial deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance (all as defined on form 395).
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No 3 Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 08. Okt. 1999
    Geliefert am 15. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Avonpark care centre,winsley rd,limpley stoke bath BA3 6HF and lakeside care centre,chapel rd,hothfield,ashford,kent TN25 4LN.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. März 1999
    Geliefert am 17. März 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises lakeside care centre chapel road ashford kent TN25 4LN. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 17. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 15. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The tenant charges the landlord the initial deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Aug. 1998
    Geliefert am 21. Aug. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge over l/hold premises at abbeygate residential home,42 quarry rd,st giles rd,winchester,hampshire SO23 ots. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 19. Apr. 1998
    Geliefert am 10. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £94,500 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    £94,500.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 10. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 09. Apr. 1998
    Geliefert am 17. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H avonpark care centre as assisted living unit winsley road limpley stoke bath BA3 6HF. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 1996
    Geliefert am 18. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at winsley sanatorium winsley wiltshire t/n's WT133458, WT106756 (part) and wt 129633 (part) including all fixtures fittings plant and machinery thereon (other than trade machinery thereon) as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 1996
    Geliefert am 18. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 1996
    Geliefert am 18. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a avonpark care centre and land adjoining being the site of the proposed avonpark nursing home winsley wiltshire t/nos.WT133458 WT106756(part) and WT129633(part) and all buildings and other structures goodwill all plant machinery and other items assignment of rents. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1994
    Geliefert am 05. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Building 5 at winsley sanatorium winsley wiltshire t/n WT106756 including all fixtures fittings plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978).
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 1994
    Geliefert am 05. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge and all the undertakings and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AVONPARK CARE CENTRE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Nov. 2010Beginn der Verwaltung
    26. Sept. 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Praktiker
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Robin David Allen
    3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Praktiker
    3 Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6GD Bristol
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0