EXOR CORPORATION LIMITED
Überblick
Unternehmensname | EXOR CORPORATION LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02898430 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EXOR CORPORATION LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich EXOR CORPORATION LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 9th Floor No. 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EXOR CORPORATION LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LEARNMUCH PROJECTS LIMITED | 15. Feb. 1994 | 15. Feb. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXOR CORPORATION LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EXOR CORPORATION LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul William Eaton als Sekretär am 01. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2014 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2013 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Voller als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2012 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Johnson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Johnson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Mai 2012 bis 30. Nov. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 12 Seiten | AR01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Clifton Heights Clifton Bristol BS8 1EJ* am 14. Nov. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von David Hollister als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Lynch als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Rowlinson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EXOR CORPORATION LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLLISTER, David | Geschäftsführer | Floor No. 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 9th United Kingdom | Usa | American | Chief Financial Officer | 161824250001 | ||||
JOHNSON, Andrew Neil | Geschäftsführer | Floor No. 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 9th United Kingdom | Usa | British | Vice President Software Development & Consultancy | 148386100001 | ||||
DASHFIELD, Kay Rosalind Clare | Sekretär | Clifton Heights Clifton BS8 1EJ Bristol | British | 46710460004 | ||||||
EATON, Paul William | Sekretär | Copthorne Bank Copthorne RH10 3JQ Crawley Alford West Sussex England | 155343000001 | |||||||
BYRON COMPANY SERVICES LIMITED | Sekretär | 7 Berkeley Square Clifton BS8 1HG Bristol | 37866710001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BEARDSHALL, Samuel Francis Rodney | Geschäftsführer | Clifton Heights Clifton BS8 1EJ Bristol | United Kingdom | British | Director | 47184440001 | ||||
DARKE, Lawrence Constable | Geschäftsführer | 4 Ribston Mews GL1 5EU Gloucester | British | Director | 73000100002 | |||||
DASHFIELD, Kay Rosalind Clare | Geschäftsführer | Badgers Wood 8 Church Road Easton In Gordano BS20 0PQ Bristol North Somerset | United Kingdom | British | Director | 46710460004 | ||||
JOHNSON, Nicholas John | Geschäftsführer | Floor No. 20 Gracechurch Street EC3V 0BG London 9th United Kingdom | England | British | Services Director | 216618540001 | ||||
LITTLEDALE, Robert Wheatley | Geschäftsführer | Highfield The Slade Charlbury OX7 3SJ Chipping Norton Oxfordshire | British | Director | 1450690001 | |||||
LOARRIDGE, Russell John, Mr. | Geschäftsführer | Clifton Heights Clifton BS8 1EJ Bristol | Uk | British | Sales Director | 133183080002 | ||||
LYNCH, John Edward | Geschäftsführer | Ne 16th Street 33304 Fort Lauderdale 2225 Florida Usa | Usa | American | Software Executive | 148387790001 | ||||
ROWLINSON, Andrew | Geschäftsführer | Clifton Heights Clifton BS8 1EJ Bristol | England | British | Director | 73000000001 | ||||
SMITH, Stephen Rhodes | Geschäftsführer | 2 Princes Building Clifton BS8 4LB Bristol Avon | United Kingdom | British | Director | 46536530001 | ||||
TAYLOR, Bryan Lloyd | Geschäftsführer | Hatch Cottage Kent Street, Cowfold RH13 8BG Horsham West Sussex | England | British | Director | 71356520002 | ||||
VOLLER, Stephen Roy | Geschäftsführer | The Grange 60 West Street BS6 6LJ Banwell North Somerset | England | British | Director | 47184600007 | ||||
WARD, John | Geschäftsführer | 37 Country Road Mamaroneck Ny 10543 Usa | British | Director | 73000370001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat EXOR CORPORATION LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 22. Okt. 2008 Geliefert am 25. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. März 2007 Geliefert am 14. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. März 2002 Geliefert am 10. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Okt. 2001 Geliefert am 02. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Okt. 2000 Geliefert am 11. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Juli 2000 Geliefert am 03. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an investment agreement and a pik note instrument both of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 06. März 1996 Geliefert am 13. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0