DEVELOP SOLUTIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDEVELOP SOLUTIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02898720
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Derby Training Centre
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ESSENTIAL MANAGMENT SERVICES LIMITED08. Juli 199808. Juli 1998
    GATEWAYS ASSOCIATES LIMITED14. März 199414. März 1994
    SPEED 4118 LIMITED15. Feb. 199415. Feb. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Liam Edward Sammon als Direktor am 13. Sept. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Gerrard Mcguire als Direktor am 13. Sept. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Jonathan Charles Graham als Direktor am 13. Sept. 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Graham Bird als Direktor am 13. Sept. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Clive Garner King als Geschäftsführer am 13. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    1 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Simon James Kelsall als Sekretär am 04. Jan. 2019

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Simon James Kelsall als Geschäftsführer am 04. Jan. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Christopher Kevin Cole als Sekretär am 18. Feb. 2019

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Christopher Gilbert Wood als Geschäftsführer am 22. Aug. 2018

    1 SeitenTM01

    legacy

    7 SeitenRP04CS01

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    1 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    1 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    1 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 24. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Derby Training Centre Ascot Drive Derby DE24 8GW verlegt

    1 SeitenAD04

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 6 Craster Court Manor Walks Cramlington Northumberland NE23 6UT United Kingdom zum Derby Training Centre Ascot Drive Derby DE24 8GW geändert

    1 SeitenAD02

    Ernennung von Mr Simon James Kelsall als Sekretär am 01. Okt. 2015

    2 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COLE, Christopher Kevin
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    Sekretär
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    255536300001
    BIRD, Paul Graham
    120-122 High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    Geschäftsführer
    120-122 High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    EnglandBritish179282780003
    GRAHAM, Jonathan Charles
    High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    Geschäftsführer
    High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    EnglandBritish55809880001
    KERR, John Newlands
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    Geschäftsführer
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    EnglandBritish199902580001
    MCGUIRE, Paul Gerrard
    120-122 High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    Geschäftsführer
    120-122 High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    EnglandIrish,British209889240001
    SAMMON, Liam Edward
    120-122 High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    Geschäftsführer
    120-122 High Street
    BR6 0JS Orpington
    Jtl Stafford House
    England
    EnglandBritish263059520001
    ALETE, Christopher Uchegbu
    The Granary
    NE40 3QQ Old Ryton Village
    Tyne & Wear
    Sekretär
    The Granary
    NE40 3QQ Old Ryton Village
    Tyne & Wear
    British70065800004
    BLACKBURN, Graeme
    Wheatfields
    NE25 0PZ Seaton Deleval
    2
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Wheatfields
    NE25 0PZ Seaton Deleval
    2
    Tyne & Wear
    British136038490001
    DUCKWORTH, Simon Charles
    13 Beverley Road
    Monkseaton
    NE25 8JH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    13 Beverley Road
    Monkseaton
    NE25 8JH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British118411750001
    EBBITT, Michael
    1 Foresters Close
    Norley
    WA6 8NN Frodsham
    Cheshire
    Sekretär
    1 Foresters Close
    Norley
    WA6 8NN Frodsham
    Cheshire
    British112320770001
    FORSYTH, William James
    16b Painshawfield Road
    NE43 7EA Stocksfield
    Northumberland
    Sekretär
    16b Painshawfield Road
    NE43 7EA Stocksfield
    Northumberland
    British36537810001
    KELSALL, Simon James
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    Sekretär
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    201447380001
    MCKEOWN, Anthony
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    Sekretär
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    147070650001
    POWELL, Alison Wendy
    Tritlington House
    Tritlington
    NE61 3ED Morpeth
    Northumberland
    Sekretär
    Tritlington House
    Tritlington
    NE61 3ED Morpeth
    Northumberland
    British107552100001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALETE, Christopher Uchegbu
    The Granary
    NE40 3QQ Old Ryton Village
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    The Granary
    NE40 3QQ Old Ryton Village
    Tyne & Wear
    British70065800004
    COLEMAN, Russell
    6 Craster Court
    Manor Walks
    NE23 6UT Cramlington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    6 Craster Court
    Manor Walks
    NE23 6UT Cramlington
    Northumberland
    United KingdomBritish126514650001
    COWELL, Stephen
    The Old Farm House
    West Thirston
    NE65 9EF Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Old Farm House
    West Thirston
    NE65 9EF Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritish13085630002
    DOUGALL, Mark
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish164276100001
    FORSYTH, William James
    16b Painshawfield Road
    NE43 7EA Stocksfield
    Northumberland
    Geschäftsführer
    16b Painshawfield Road
    NE43 7EA Stocksfield
    Northumberland
    British36537810001
    HENDERSON, Jacqueline
    The Old Manse
    4 High Market
    NE63 8PD Ashington
    Geschäftsführer
    The Old Manse
    4 High Market
    NE63 8PD Ashington
    EnglandBritish115032090001
    KELSALL, Simon James
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    Geschäftsführer
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    EnglandBritish201446940001
    KING, Anthony Clive Garner
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    Geschäftsführer
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    EnglandBritish108853950001
    MCKEOWN, Anthony
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish148670820001
    POWELL, Alison Wendy
    Tritlington House
    Tritlington
    NE61 3ED Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Tritlington House
    Tritlington
    NE61 3ED Morpeth
    Northumberland
    British107552100001
    TOMPSETT, Rodney Graham
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish30964760003
    WOOD, Christopher Gilbert
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    Geschäftsführer
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Derby Training Centre
    EnglandBritish136806990001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Develop Training Centre
    06. Apr. 2016
    Ascot Drive
    DE24 8GW Derby
    Develop Training Centre
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006 England And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer06299573
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat DEVELOP SOLUTIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2010
    Geliefert am 29. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rod Tompsett
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. März 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2010
    Geliefert am 29. Sept. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Unquoted Investments Limited
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 20. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the investor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Unquoted Investments Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2007
    Geliefert am 12. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Unquoted Investments Limited
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Dez. 2002
    Geliefert am 27. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due or to become due from longhirst group limited (crn) to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0