DEVELOP SOLUTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DEVELOP SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02898720 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Derby Training Centre Ascot Drive DE24 8GW Derby |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ESSENTIAL MANAGMENT SERVICES LIMITED | 08. Juli 1998 | 08. Juli 1998 |
| GATEWAYS ASSOCIATES LIMITED | 14. März 1994 | 14. März 1994 |
| SPEED 4118 LIMITED | 15. Feb. 1994 | 15. Feb. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Liam Edward Sammon als Direktor am 13. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Gerrard Mcguire als Direktor am 13. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Charles Graham als Direktor am 13. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Graham Bird als Direktor am 13. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Clive Garner King als Geschäftsführer am 13. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon James Kelsall als Sekretär am 04. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon James Kelsall als Geschäftsführer am 04. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Kevin Cole als Sekretär am 18. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Gilbert Wood als Geschäftsführer am 22. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Derby Training Centre Ascot Drive Derby DE24 8GW verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 6 Craster Court Manor Walks Cramlington Northumberland NE23 6UT United Kingdom zum Derby Training Centre Ascot Drive Derby DE24 8GW geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon James Kelsall als Sekretär am 01. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLE, Christopher Kevin | Sekretär | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre | 255536300001 | |||||||
| BIRD, Paul Graham | Geschäftsführer | 120-122 High Street BR6 0JS Orpington Jtl Stafford House England | England | British | 179282780003 | |||||
| GRAHAM, Jonathan Charles | Geschäftsführer | High Street BR6 0JS Orpington Jtl Stafford House England | England | British | 55809880001 | |||||
| KERR, John Newlands | Geschäftsführer | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre | England | British | 199902580001 | |||||
| MCGUIRE, Paul Gerrard | Geschäftsführer | 120-122 High Street BR6 0JS Orpington Jtl Stafford House England | England | Irish,British | 209889240001 | |||||
| SAMMON, Liam Edward | Geschäftsführer | 120-122 High Street BR6 0JS Orpington Jtl Stafford House England | England | British | 263059520001 | |||||
| ALETE, Christopher Uchegbu | Sekretär | The Granary NE40 3QQ Old Ryton Village Tyne & Wear | British | 70065800004 | ||||||
| BLACKBURN, Graeme | Sekretär | Wheatfields NE25 0PZ Seaton Deleval 2 Tyne & Wear | British | 136038490001 | ||||||
| DUCKWORTH, Simon Charles | Sekretär | 13 Beverley Road Monkseaton NE25 8JH Whitley Bay Tyne & Wear | British | 118411750001 | ||||||
| EBBITT, Michael | Sekretär | 1 Foresters Close Norley WA6 8NN Frodsham Cheshire | British | 112320770001 | ||||||
| FORSYTH, William James | Sekretär | 16b Painshawfield Road NE43 7EA Stocksfield Northumberland | British | 36537810001 | ||||||
| KELSALL, Simon James | Sekretär | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre | 201447380001 | |||||||
| MCKEOWN, Anthony | Sekretär | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre United Kingdom | 147070650001 | |||||||
| POWELL, Alison Wendy | Sekretär | Tritlington House Tritlington NE61 3ED Morpeth Northumberland | British | 107552100001 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| ALETE, Christopher Uchegbu | Geschäftsführer | The Granary NE40 3QQ Old Ryton Village Tyne & Wear | British | 70065800004 | ||||||
| COLEMAN, Russell | Geschäftsführer | 6 Craster Court Manor Walks NE23 6UT Cramlington Northumberland | United Kingdom | British | 126514650001 | |||||
| COWELL, Stephen | Geschäftsführer | The Old Farm House West Thirston NE65 9EF Morpeth Northumberland | England | British | 13085630002 | |||||
| DOUGALL, Mark | Geschäftsführer | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 164276100001 | |||||
| FORSYTH, William James | Geschäftsführer | 16b Painshawfield Road NE43 7EA Stocksfield Northumberland | British | 36537810001 | ||||||
| HENDERSON, Jacqueline | Geschäftsführer | The Old Manse 4 High Market NE63 8PD Ashington | England | British | 115032090001 | |||||
| KELSALL, Simon James | Geschäftsführer | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre | England | British | 201446940001 | |||||
| KING, Anthony Clive Garner | Geschäftsführer | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre | England | British | 108853950001 | |||||
| MCKEOWN, Anthony | Geschäftsführer | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 148670820001 | |||||
| POWELL, Alison Wendy | Geschäftsführer | Tritlington House Tritlington NE61 3ED Morpeth Northumberland | British | 107552100001 | ||||||
| TOMPSETT, Rodney Graham | Geschäftsführer | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre United Kingdom | England | British | 30964760003 | |||||
| WOOD, Christopher Gilbert | Geschäftsführer | Ascot Drive DE24 8GW Derby Derby Training Centre | England | British | 136806990001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DEVELOP SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Develop Training Group Limited | 06. Apr. 2016 | Ascot Drive DE24 8GW Derby Develop Training Centre | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DEVELOP SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Sept. 2010 Geliefert am 29. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. Sept. 2010 Geliefert am 29. Sept. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 20. Jan. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the investor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Nov. 2007 Geliefert am 12. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Dez. 2002 Geliefert am 27. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due or to become due from longhirst group limited (crn) to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0