LAB M LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LAB M LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02903063 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LAB M LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich LAB M LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LAB M LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IDG (UK) LIMITED | 16. Apr. 1996 | 16. Apr. 1996 |
| MALTHUS INTERNATIONAL LIMITED | 22. Apr. 1994 | 22. Apr. 1994 |
| SWIRLPORT LIMITED | 28. Feb. 1994 | 28. Feb. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAB M LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LAB M LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Juni 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Juni 2023
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2022 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2021 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2020 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Dr Jason Lilly als Direktor am 05. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Adent als Direktor am 05. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven James Donnachie als Direktor am 05. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Jeffrey Irwin Holmes als Geschäftsführer am 05. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2019 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Lamar Herbert als Geschäftsführer am 01. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 029030630010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LAB M LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENT, John Edward | Geschäftsführer | Auchincruive KA6 5HU Ayr The Dairy School Scotland | United States | American | 267191700001 | |||||
| DONNACHIE, Steven James | Geschäftsführer | Auchincruive KA6 5HU Ayr The Dairy School Scotland | Scotland | British | 268212170001 | |||||
| LILLY, Jason Warren | Geschäftsführer | Auchincruive KA6 5HU Ayr The Dairy School Scotland | United States | American | 290589050001 | |||||
| QUINLAN, Steven | Geschäftsführer | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United States | American | 203110190001 | |||||
| BROWN, Michael Stewart | Sekretär | Flat 6 Derwent Park House New Road DE22 1DR Derby | British | 86327240001 | ||||||
| COTTON, Angela | Sekretär | 3 Ravens Holme BL1 5TN Bolton Greater Mancheseter | British | 62018140001 | ||||||
| DUNBAR, Stephen John | Sekretär | 43 Cotswold Drive Horwich BL6 7DE Bolton Lancashire | British | 46237640003 | ||||||
| JAMES, Richard David | Sekretär | 19 Mill Close WA2 0ST Warrington Cheshire | British | 80458850001 | ||||||
| MCMAHON, Gregory Joseph | Sekretär | 7 St Johns Court Lees OL4 3LN Oldham Lancashire | British | 49723980001 | ||||||
| RAPSON, Bernard David | Sekretär | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | British | 3213310001 | ||||||
| SMITH, Paul Gareth | Sekretär | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | 184015420001 | |||||||
| SULLIVAN, Mark James | Sekretär | 2 Grange Barn Malt Kiln Lane Bispham L40 3SH Ormskirk Lancashire | British | 101060960001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 38962110003 | |||||||
| CLYDE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 51 Eastcheap EC3M 1JP London | 38770650001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BOND, Damian Joseph Peter | Geschäftsführer | 3 The Greens Todmorden Road OL13 9HJ Bacup Lancashire | England | British | 56681240003 | |||||
| BONDSWELL, Andrew | Geschäftsführer | 19 Brier Hill View HD2 1JQ Huddersfield West Yorkshire | British | 62729310001 | ||||||
| BOWHILL, Keith Nicholas | Geschäftsführer | Woodside Sandy Lane Rushmoor GU10 2ET Farnham Surrey | British | 61679460002 | ||||||
| BUHL, Christian | Geschäftsführer | Noddegangen 9 FOREIGN Holte Dk 2840 Denmark | Danish | 30528580001 | ||||||
| CASSELLS, John Maclaren, Dr | Geschäftsführer | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 63881080001 | |||||
| FRASER-ALLEN, William Thomas | Geschäftsführer | Kings Arms Yard EC2R 7AF London 1 England | England | British | 150535240001 | |||||
| GOODWILLE, Colin | Geschäftsführer | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 3856830002 | |||||
| GOODWILLE, Fiona Ford | Geschäftsführer | The Old Rectory Church Lane CB3 8QN Papworth Everard Cambridge | British | 20914960001 | ||||||
| GUNLACK, Robert Henry | Geschäftsführer | Treviades Barton High Cross Constantine TR11 5RG Falmouth Cornwall | England | British | 27971040006 | |||||
| HERBERT, James Lamar | Geschäftsführer | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United States | American | 200649010001 | |||||
| HILLARY, Alan | Geschäftsführer | 1 Cameron Close GU6 8EB Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 13184060001 | |||||
| HOLMES, Stephen Jeffrey Irwin, Dr | Geschäftsführer | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire | United Kingdom | British | 200627160001 | |||||
| KELLY, Derek | Geschäftsführer | 20 Woodland Close Verwood BH31 7PN Bournemouth Dorset | British | 116389600001 | ||||||
| MORRIS, Ian Leslie | Geschäftsführer | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | United Kingdom | British | 138377860001 | |||||
| PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor | Geschäftsführer | Amersham Road HP13 6QS High Wycombe 21 Buckinghamshire | England | British | 17972160001 | |||||
| RAPSON, Bernard David | Geschäftsführer | Bank Cottage Old Forge Lane Preston Capes NN11 3TD Daventry Northamptonshire | England | British | 3213310001 | |||||
| SAVAGE, Barry David | Geschäftsführer | 43 Hawkstone Road Whitefield M45 7PR Manchester | British | 55824670001 | ||||||
| SCHRODER, Johan | Geschäftsführer | Taarbaek Strandvej 24 DK 2930 Klampenborg Denmark | Danish | 3856860004 | ||||||
| SMITH, Paul Gareth | Geschäftsführer | Quest Park Moss Hall Road BL9 7JJ Heywood 1 Lancashire England | England | British | 187422070001 | |||||
| SMITH, Peter James | Geschäftsführer | 19 Coolidge Avenue LA1 5ER Lancaster | British | 37288990001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LAB M LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab M Holdings Ltd | 06. Apr. 2016 | Moss Hall Road BL9 7JJ Bury 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LAB M LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 31. Okt. 2013 Geliefert am 07. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Unit 3 quest park, moss hall road, heywood, lancashire. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Aug. 2011 Geliefert am 19. Aug. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1 & 2 quest park moss hall road heywood lancashire part of t/no. MAN137583 and all easements and rights attached to such property and all buildings, fixtures and other structures and fixed plant and machinery from time to time thereon see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 2011 Geliefert am 19. Aug. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 1 & 2 quest park, moss hall road, heywood, lancashire t/no MAN137583 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Aug. 2011 Geliefert am 13. Aug. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Aug. 2011 Geliefert am 05. Aug. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Jan. 2002 Geliefert am 30. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Dez. 1995 Geliefert am 22. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts.floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Nov. 1995 Geliefert am 02. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or by the companies hereinafter defined ("the customer") and all monies agreed to be paid by the company in accordance with the provisions of any guarantee or guarantees given by the company to the yorkshire bank public limited company in respect of the indebtedness and liability of the customer or any company or companies which may constitute a sub sidiary or subsidiaries of the charging company or any company or companies which may be otherwise associated with the charging company in business | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Mai 1995 Geliefert am 23. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0