EDMONTON GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEDMONTON GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02904479
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EDMONTON GROUP LIMITED?

    • (7420) /

    Wo befindet sich EDMONTON GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EDMONTON GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DBK GROUP LIMITED05. Juni 200905. Juni 2009
    DBK BACK LIMITED16. Okt. 200616. Okt. 2006
    BACK GROUP LIMITED18. Juli 200018. Juli 2000
    THE DAVID BACK GROUP LIMITED31. März 199431. März 1994
    OAKBRIGHT LIMITED03. März 199403. März 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EDMONTON GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für EDMONTON GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für EDMONTON GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    14 Seiten4.72

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement liquidator
    36 SeitenLIQ MISC OC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Jan. 2014

    9 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Enterprise House 115 Edmund Street Birmingham B3 2HJ am 16. Apr. 2013

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 31. Jan. 2013

    9 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Feb. 2012

    9 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 321 Bradford Street Birmingham B5 6ET United Kingdom am 24. Aug. 2011

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    21 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    11 Seiten2.16B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed dbk group LIMITED\certificate issued on 01/04/11
    3 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 18. März 2011

    RES15

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 18. März 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Gordon Balharrie als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Addis als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Roger Adams als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. März 2010

    Kapitalaufstellung am 11. März 2010

    • Kapital: GBP 84.95
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Martin Kennedy am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    22 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Gordon Alexander Balharrie am 30. März 2007

    1 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von EDMONTON GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASSEY, Andrew Joseph
    Ranikhet
    Wenlock Road
    WV16 5AZ Bridgnorth
    Shropshire
    Sekretär
    Ranikhet
    Wenlock Road
    WV16 5AZ Bridgnorth
    Shropshire
    British62344120004
    BERRY, Duncan Steven
    27 Oakham Road
    Harborne
    B17 9DQ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    27 Oakham Road
    Harborne
    B17 9DQ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishQuantity Surveyor94586760001
    DOWNING, Timothy James
    Cruck Barn
    Chetton
    WV16 6UF Bridgnorth
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Cruck Barn
    Chetton
    WV16 6UF Bridgnorth
    Shropshire
    EnglandBritishDirector38793840002
    KELLY, Steven Paul
    Middle Mill
    Stratford Road Wooton Wawen
    B95 6BY Henley In Arden
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Middle Mill
    Stratford Road Wooton Wawen
    B95 6BY Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandBritishQuantity Surveyor94587020002
    KENNEDY, Andrew Martin
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    Geschäftsführer
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    United KingdomBritishQuantity Surveyor51174310001
    WADLOW, Lawrence
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    British38794190001
    WEBB, Paul John
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    BritishQuantity Surveyor38794230001
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Bevollmächtigter Sekretär
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    ADAMS, Roger William
    60 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    Geschäftsführer
    60 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishQuantity Surveyor49690040001
    ADDIS, Jonathan Peter
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Finance Director260439420001
    BACK, David Ronald
    Fairfield
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JZ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Fairfield
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JZ Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishQuantity Surveyor38545940001
    BALHARRIE, Gordon Alexander
    Waverley Avenue
    Berrylands
    KT5 9HD Surbiton
    23
    Surrey
    Geschäftsführer
    Waverley Avenue
    Berrylands
    KT5 9HD Surbiton
    23
    Surrey
    United KingdomBritishQuantity Surveyor158788510001
    BLACK, Philip Howard
    119 Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    Geschäftsführer
    119 Wentworth Road
    B17 9SU Birmingham
    BritishDirector87058240001
    DANDO, Ralph Henry
    Poplar Cottage
    Pebmarsh
    CO9 2QE Halstead
    Essex
    Geschäftsführer
    Poplar Cottage
    Pebmarsh
    CO9 2QE Halstead
    Essex
    BritishCivil Engineer142509180001
    MUSE, Alan George
    5 Grove Road
    SL4 1JE Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Grove Road
    SL4 1JE Windsor
    Berkshire
    BritishProject Manager66902080002
    STEWART, Alan Wright
    17 Warren Drive
    DY3 3RQ Dudley
    West Midlands
    Geschäftsführer
    17 Warren Drive
    DY3 3RQ Dudley
    West Midlands
    EnglandBritishProject Manager66105690001
    WADLOW, Lawrence
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    19 Lakeside Drive
    Monkspath
    B90 4SX Solihull
    West Midlands
    BritishQuantity Surveyor38794190001
    WEBB, Paul John
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    11 Woodstock Crescent
    Dorridge
    B93 8DA Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishQuantity Surveyor38794230001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    Hat EDMONTON GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 11. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Roger William Adams, Andrew Martin Kennedy, Gordon Alexander Balharrie
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Aug. 2005
    Geliefert am 23. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 12. Aug. 2005
    Geliefert am 23. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right to receive payment in the policy of insurance number 14/6176818-0 and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 12. Aug. 2005
    Geliefert am 23. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right to receive payment in the policy of insurance number 14/6176896-2 and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 12. Aug. 2005
    Geliefert am 23. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any right to receive payment in the policy of insurance number 14/6176803-2 and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2004
    Geliefert am 13. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 01. Juni 2001
    Geliefert am 05. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re;-back group limited now numbered 07318904 and any account(s) replacing the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 04. Mai 1994
    Geliefert am 10. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EDMONTON GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Feb. 2012Ende der Verwaltung
    04. Feb. 2011Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David James Bennett
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Praktiker
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    2
    DatumTyp
    01. Feb. 2012Beginn der Liquidation
    13. Apr. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David James Bennett
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Praktiker
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praktiker
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0