FASCIA GRAPHICS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FASCIA GRAPHICS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02904839 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FASCIA GRAPHICS LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich FASCIA GRAPHICS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Poppleton & Appleby The Media Centre 7 Northumberland Street HD1 1RL Huddersfield |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FASCIA GRAPHICS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FASCIA GRAPHICS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bath Road Industrial Estate Chippenham Wiltshire SN14 0AB zum C/O Poppleton & Appleby the Media Centre 7 Northumberland Street Huddersfield HD1 1RL am 13. Mai 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2018 bis 30. Sept. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicola Burchill als Sekretär am 31. März 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Notification of Worldmark Uk Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Paul Andrew Bennett as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Ernest William Griffin as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrew Bennett als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ernest William Griffin als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Anthony Beckram als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Andrew Sanderson als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Derek Cumming als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ernest William Griffin als Sekretär am 01. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FASCIA GRAPHICS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKRAM, Mark Anthony | Geschäftsführer | Pioneer Way WF10 5QU Castleford Unit 3 England | United Kingdom | British | 119588680001 | |||||
| CUMMING, Derek Robert | Geschäftsführer | Redwood Crescent East Kilbride G74 5PA Glasgow 4 Scotland | Scotland | British | 206110120001 | |||||
| SANDERSON, Michael Andrew | Geschäftsführer | Redwood Crescent East Kilbride G74 5PA Glasgow 4 Scotland | Scotland | British | 108870500001 | |||||
| BURCHILL, Nicola | Sekretär | Bath Road Industrial Estate Chippenham SN14 0AB Wiltshire | 201768150001 | |||||||
| GRIFFIN, Ernest William | Sekretär | Ebor Gardens SN11 0AJ Calne 2 Wiltshire England | British | 1831110002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BENNETT, Paul Andrew | Geschäftsführer | 26 Lickhill Road SN11 9DE Calne Wiltshire | England | British | 39425230003 | |||||
| GRIFFIN, Ernest William | Geschäftsführer | Ebor Gardens SN11 0AJ Calne 2 Wiltshire England | England | British | 1831110002 | |||||
| LAW, John Edward | Geschäftsführer | 12 Braemor Road SN11 9DT Calne Wiltshire | British | 37988550001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FASCIA GRAPHICS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldmark Uk Limited | 31. Jan. 2018 | Redwood Crescent East Kilbride G74 5PA Glasgow 4 Scotland | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
| Mr Ernest William Griffin | 06. Apr. 2016 | Bath Road Industrial Estate Chippenham SN14 0AB Wiltshire | Ja | ||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
| Mr Paul Andrew Bennett | 06. Apr. 2016 | Bath Road Industrial Estate Chippenham SN14 0AB Wiltshire | Ja | ||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat FASCIA GRAPHICS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Erstellt am 24. März 2006 Geliefert am 01. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a bath road industrial estate, chippenham, wiltshire t/no WT140710 and WT137153. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Jan. 2006 Geliefert am 26. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. März 2005 Geliefert am 12. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 5 bath road industrial estate chippenham t/n WT137153. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. März 2005 Geliefert am 12. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Storage land at bath road industrial estate chippenham wiltshire t/n WT140710. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 1997 Geliefert am 29. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 09. Okt. 1995 Geliefert am 12. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat FASCIA GRAPHICS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0