SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02905929 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| M&R 6OO LIMITED | 08. März 1994 | 08. März 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Gillian Elizabeth James am 31. März 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Charles Gale am 31. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Mario Mackenzie als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 160 Great Portland Street London W1W 5QA am 31. März 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 25 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
Ernennung von Robert Mario Mackenzie als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Directors Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | 151395760001 | |||||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 96956740001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| ASHBURNER, Ronald Leslie George | Sekretär | 5 The Avenue UB10 8NR Uxbridge Middlesex | British | 102503610001 | ||||||
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | 148 Selwyn Avenue Highams Park E4 9LS London | British | 72139660001 | ||||||
| LUBASCH, Richard Joel | Sekretär | 4 Beech Tree Lane NEW YORK Brookville 11545 Usa | British | 81075820001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | 47785600002 | ||||||
| MARSHALL, Brian | Bevollmächtigter Sekretär | Owls Hall Chimney Street Hundon CO10 8DX Sudbury Suffolk | British | 900008320001 | ||||||
| PROCTOR, Martina | Sekretär | 37a Madingley Road CB3 0EL Cambridge | British | 43777590001 | ||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| ALDEN, Peter James | Geschäftsführer | 32 Brookside CB2 1JQ Cambridge | British | 40967330002 | ||||||
| BARLEY, Michael Desmond Tennyson | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fowlmere Road Heydon SG8 8PZ Royston Hertfordshire | British | 900008310001 | ||||||
| CAMPBELL, Gerald Daniel | Geschäftsführer | 18 Ringwood Avenue N2 9NS London | American | 48066760001 | ||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||
| CHEW, Mun Chun | Geschäftsführer | 15 Rectory Farm Road Little Wilbraham CB1 5LB Cambridge | Singaporean | 36124880001 | ||||||
| DAVENPORT, Hugo Riddell Agard Bramhall | Geschäftsführer | 19 Wingate Way CB2 2HD Cambridge Cambridgeshire | British | 6298250001 | ||||||
| DAVIES, Richard James | Geschäftsführer | The Library Suite The Mansion KT16 0QB Ottershaw Park Surrey | American | 45182540001 | ||||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Station Road KT7 0NS Thames Ditton 42 Surrey | England | British | 96956740001 | |||||
| GOWEN, Wayne Lyle | Geschäftsführer | New House Fairoak Lane Oxshott KT22 0TP Leatherhead Surrey | British | 39694410001 | ||||||
| GREGG, John Francis | Geschäftsführer | 411 Silvermoss Drive Vero Beach Florida 32963 America | American | 75381740001 | ||||||
| HO, Lam Phoh | Geschäftsführer | 129 Tanah Kerah Kechill Road 1646 Singapore | Singaporean | 36156430001 | ||||||
| KELHAM, David William | Geschäftsführer | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | 87146390001 | |||||
| KNAPP, James Barclay | Geschäftsführer | 54 Hodge Road Princeton New Jersey 08540 Usa | Us Citizen | 79688880001 | ||||||
| LAWLEY, Ronald Edward | Geschäftsführer | 28 Hurst Park GU29 0BP Midhurst West Sussex | United Kingdom | British | 121475980001 | |||||
| LEW, Allen Yoong Keong | Geschäftsführer | 52 Nallur Road Singapore 1545 | Singaporean | 44257660001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MCKELLAR, Ronald Alexander | Geschäftsführer | Halstead Stratfield Saye RG7 2EJ Reading Berkshire | British | 7345780001 | ||||||
| MIZGA, Gary Lamont | Geschäftsführer | Nuthatch Prey Heath Common Mayford GU22 0SL Woking Surrey | Usa | 55553500001 | ||||||
| RICHTER, Bret | Geschäftsführer | 245 East 63rd Street Apartment 20h 10021 New York New York United States | American | 86830760001 | ||||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Geschäftsführer | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||
| ROSS, Stuart | Geschäftsführer | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 | |||||
| SCHUBERT, Scott Elliott | Geschäftsführer | 9 William Street House William Street SW1X 9HH London | American | 89618040001 | ||||||
| SUNG, Sio Ma | Geschäftsführer | 17 Phillips Avenue FOREIGN Singapore 1954 Singapore | Singaporean | 84957060001 |
Hat SOUTHERN EAST ANGLIA CABLE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 29. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance contingent or otherwise and undertakings arising under or in obligations connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An alternative bridge composite debenture | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 29. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 23. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 06. Jan. 1998 Geliefert am 23. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whether actual or contingent now or hereafter due, owing or incurred to the chargee in its capacity as security trustee by the company and/or all or any of the other companies named therein under or pursuant to the agreement and/or the composite guarantee and debenture and/or the security trust deed and/or any of the other security documents, all obligations and liabilities due owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein to the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements, and to the bond providers, if any (or any of them) in respect of any indemnity from the company and/or all or any of the other companies named therein issued in connection with the bond provision arrangements | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0