JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02916253 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?
- (5510) /
Wo befindet sich JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Castle House Desborough Road HP11 2PR High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
GOULDITAR NO.349 LIMITED | 06. Apr. 1994 | 06. Apr. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 16 Seiten | MG01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Francis Jarvis am 05. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen James Hebborn am 05. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Duncan Jeremy Graham Beveridge am 05. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Tunney als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrews als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. März 2005 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s |
Wer sind die Geschäftsführer von JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERIDGE, Duncan Jeremy Graham | Sekretär | Castle House Desborough Road HP11 2PR High Wycombe Buckinghamshire | British | 65651540002 | ||||||
HEBBORN, Stephen James | Geschäftsführer | Castle House Desborough Road HP11 2PR High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Director | 100382260002 | ||||
JARVIS, John Francis | Geschäftsführer | Castle House Desborough Road HP11 2PR High Wycombe Buckinghamshire | England | British | Company Director | 941890002 | ||||
BURNINGHAM, Derek | Sekretär | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | Company Secretary | 3360080001 | |||||
MEENAGHAN, Evelyn Maria | Bevollmächtigter Sekretär | 48 Cedars Avenue E17 7QN London | British | 900001370001 | ||||||
VINTNER, Barry Sanders | Sekretär | Maracus Cottage Springwell Lane Harefield UB9 6PG Uxbridge Middlesex | British | Company Secretary | 8022040001 | |||||
ANDREWS, David | Geschäftsführer | 6 Arkendale Road IRISH Glengeary County Dublin Ireland | Ireland | Irish | Director | 91041230001 | ||||
LEWIS, Roland Peter | Geschäftsführer | Driftstone Manor Middle Way Kingston Gorse BN16 1SB East Preston West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 35930190001 | ||||
SEATON, Stuart Neil | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 Priory Walk SW10 9SP London | United Kingdom | British | 900001360001 | |||||
THOMAS, David Owen | Geschäftsführer | 7 Misbourne House Amersham Road HP8 4RY Chalfont St. Giles Buckinghamshire | British | Company Director | 642560002 | |||||
THOMASON, Richard Wooler | Geschäftsführer | 1 Minerva Drive WD24 5LD Watford Hertfordshire | British | Director | 84700430001 | |||||
TUNNEY, Michael | Geschäftsführer | Argyle House 18 Argyle Road IRISH Donnybrook Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | Director | 114779640002 |
Hat JARVIS HOTELS - CREATING THE DIFFERENCE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Erstellt am 15. März 2010 Geliefert am 25. März 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession to the guarantee and fixed and floating security document dated 11 december 2003 | Erstellt am 16. März 2004 Geliefert am 19. März 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 28. Dez. 1995 Geliefert am 08. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the facilities agreement and this guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 04. Juli 1995 Geliefert am 12. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties(the security trustee) and/or any of the banks(as defined) under the terms of a mortgage debenture dated 25 may 1994 and an overage and share allotment agreement dated 26 may 1994 | |
Kurze Angaben All that l/h land k/as land on the east side of ryden avenue,leyland,south ribble,lancashire.t/no.LA585390 and the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures on any such property belonging to or charged to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of rectification and confirmatory charge | Erstellt am 04. Aug. 1994 Geliefert am 08. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the overage agreement and all other liabilities due from the company to the secured parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Abbey park resort hotel, 77/79 the mount, york, 6 park street, york, north yorks t/no.NYK20021. Felbridge resort hotel, london road, east grinstead, west sussex t/nos. WSX152491 and WSX132597. Wetherby resort hotel leeds road wetherby west yorkshire t/nos.WYK69964 and WYK173127, WYK523521 (formerly YK2088) WYK523522 (formerly YK123315) and WYK523325 (formerly YK1646). Leyland resort hotel, leyland way, leyland, preston, lancashire t/no.LA585390. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 25. Mai 1994 Geliefert am 10. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from goulditar no. 349 limited (now known as jarvis hotels - creating the difference limited) to the chargee and all monies due from the company to the secured parties pursuant to the terms of the overage agreement and all other liabilities of the company to any of the secured parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben Property k/a wetherby resort hotel leeds road wetherby west yorks. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulitar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben L/H property k/a leyland resort hotel leyland way leyland preston lancashire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee all monies due secured on property acquied by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben Property k/a felbridge resort hotel london road east grinstead west sussex. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben Property k/a abbey park resort hotel the mount york and 6 park street york. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 27. Okt. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben The abbey park hotel the mount york and 6 park street york. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 27. Okt. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH 1994 | |
Kurze Angaben Property k/a felbridge hotel furze lane east grinstead west sussex. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 27. Okt. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben L/H property k/a land east of ryden avenue leyland now k/a the mercury motor inn. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 27. Okt. 1992 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben The wetherby grill and the wetherby turnpike motor inn wetherby west yorks.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Mai 1988 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben L/H property k/a four acres land to east of ryden avenue leyland south ribble lancashire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Mai 1988 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH 1994 | |
Kurze Angaben The ladbroke mercury hotel leeds road wetherby west yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Mai 1988 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben The abbey park hotel the mount york and 6 park street york. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Mai 1988 Erworben am 25. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due secured on property acquired by goulditar no 349 limited on 25TH may 1994 | |
Kurze Angaben Ye old felbridge hotel and land adjoining furze lane east grinstead west sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0