ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02917485 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Connexions 159 Princes Street IP1 1QJ Ipswich |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ENTERPRISE PROPERTY GROUP LIMITED | 07. Sept. 2007 | 07. Sept. 2007 |
| ASHTENNE RESIDENTIAL LIMITED | 10. Jan. 1996 | 10. Jan. 1996 |
| ELLINGWELL LIMITED | 11. Apr. 1994 | 11. Apr. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Dez. 2022 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 01. Dez. 2023 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Aug. 2024 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Sept. 2024 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 31. Aug. 2023 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2026 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2025 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 5 Seiten | NDISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Scutches Barn 17 High Street Whittlesford Cambridge CB22 4LT England zum Connexions 159 Princes Street Ipswich IP1 1QJ am 15. Jan. 2024 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert James Morell Keatley als Geschäftsführer am 20. Dez. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dominic Henry Johnstone White als Geschäftsführer am 20. Dez. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Charles Micklethwaite als Geschäftsführer am 18. Dez. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Robert Stocking als Geschäftsführer am 30. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon John Brown als Geschäftsführer am 30. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Brown als Sekretär am 30. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2022 bis 30. Dez. 2022 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katy Sarah Jordan als Geschäftsführer am 19. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Brown als Sekretär am 09. März 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marilyn Ann Gibb-Rice als Sekretär am 09. März 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Katy Sarah Jordan als Direktor am 17. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katy Sarah Jordan als Geschäftsführer am 17. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Katy Sarah Jordan als Direktor am 17. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 029174850015, erstellt am 11. Okt. 2022 | 27 Seiten | MR01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVISON, Neil John | Geschäftsführer | 159 Princes Street IP1 1QJ Ipswich Connexions | England | British | 39292900013 | |||||
| BROWN, Simon | Sekretär | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | 306502990001 | |||||||
| BROWN, Simon John | Sekretär | Beckbrook Equestrian Centre Oakington Road Girton CB3 0QH Cambridge | British | 72693260002 | ||||||
| DAVISON, Neil John | Sekretär | Church House Church Lane CB1 6PL Bartlow Cambridgeshire | British | 39292900002 | ||||||
| GIBB-RICE, Marilyn Ann | Sekretär | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | 248650910001 | |||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| BROWN, Simon John | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | United Kingdom | British | 72693260002 | |||||
| JONES, Morgan Lewis | Geschäftsführer | First Street SW3 2LB London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 10146340004 | |||||
| JORDAN, Katy Sarah | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | England | British | 301408910001 | |||||
| JORDAN, Katy Sarah | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | England | British | 209957990001 | |||||
| KEATLEY, John Rankin Macdonald | Geschäftsführer | Melbourn Lodge SG8 6AL Royston Hertfordshire | United Kingdom | British | 23509620001 | |||||
| KEATLEY, Robert James Morell | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | United Kingdom | British | 94753520002 | |||||
| MICKLETHWAITE, Christopher Charles | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | England | British | 50904570003 | |||||
| MICKLETHWAITE, Christopher Charles | Geschäftsführer | Friars Elm Dogkennel Green Ranmore RH5 6SU Dorking Surrey | England | British | 50904570002 | |||||
| MORRISON, Gordon | Geschäftsführer | Carldane Court Bromley Lane SG10 6HU Much Hadham Hertfordshire | England | British | 1087030003 | |||||
| STOCKING, Peter Robert | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | England | British | 69569450003 | |||||
| WATSON, Ian Richard | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | England | British | 68256540001 | |||||
| WATSON, Ian Richard | Geschäftsführer | Old Dove House Annables Lane AL5 3PR Harpenden Hertfordshire | England | British | 68256540001 | |||||
| WHITE, Anthony Johnstone | Geschäftsführer | Workham Farm Fifield OX7 6HS Chipping Norton Oxfordshire | United Kingdom | British | 1674470001 | |||||
| WHITE, Dominic Henry Johnstone | Geschäftsführer | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | England | British | 70488140005 | |||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Property Group Limited | 27. Apr. 2018 | High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
| Mr Neil John Davison | 06. Apr. 2016 | 17 High Street Whittlesford CB22 4LT Cambridge Scutches Barn England | Ja | ||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 11. Okt. 2022 Geliefert am 17. Okt. 2022 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All the chargor's share of and interest now or hereafter subsisting ("the relevant interest") in railway square (chelmsford) LLP including: (a) all distributions, profit shares, interests and bonuses and other income arising out of or accruing in respect of the relevant interest; and (b) all voting and other rights, powers, privileges and other benefits conferred by the relevant interest.. For more details please refer to the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 11. Apr. 2022 Geliefert am 25. Apr. 2022 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All the chargor’s share of and interest now or hereafter subsisting (“the relevant interest”) in high street (harston) LLP, a limited liability partnership incorporated in england and wales whose registered office is scutches barn, 17 high street, whittlesford, cambs, CB22. 4LT (“the LLP”) including:. (A) all distributions, profit shares, interests and bonuses and other income arising. Out of or accruing in respect of the relevant interest; and. (B) all voting and other rights, powers. For more details of the assets charged please refer to the instrument. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 14. Nov. 2008 Geliefert am 21. Nov. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower or the company or enterprise to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its partnership interest and its related rights meaning all distributions, all assets and rights derived from, incidental to or offered in exchange for, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 05. Nov. 2008 Geliefert am 07. Nov. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £442,000 due or to become due | |
Kurze Angaben Crossroads, water lane, helions bumpstead, halstead, essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Nov. 2002 Geliefert am 20. Nov. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at lower farm barley herts. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Feb. 2002 Geliefert am 21. Feb. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the south of meadow way great offley hitchin. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Jan. 2002 Geliefert am 02. Feb. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The former rectory market place kettering northamptonshire and garden ground t/n-NN219496. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge between the company and enterprise heritage capital limited trading together as the enterprise heritage development partnership ("the mortgagor")(1) the bank (2) | Erstellt am 02. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the legal charge | |
Kurze Angaben All that land adjoining 49 market hill, maldon with all buildings and erections thereon and all fixtures and fittings therein and all services and means of access. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge over cash between the company and enterprise heritage capital limited together as the enterprise heritage development partnership (the customer) and the chargee | Erstellt am 18. Aug. 2000 Geliefert am 23. Aug. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any account of the customer held by the bank as referred to in facility letter dated 9TH august 2000 addressed from the bank to the customer and any agreement or letter amending supplementing or replacing the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A legal charge between the company and enterprise heritable capital limited trading together as the enterprise heritage development partnership and the chargee | Erstellt am 18. Aug. 2000 Geliefert am 23. Aug. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 33 and 35 market hill maldon - EX634204 ; f/h property k/a 37 market hill maldon - ex 634203 ; f/h property k/a land on the west side of market hill maldon - EX476477 (see M395 for other properties) and including all buildings and erections thereon and all services and means of access and egress thereto and therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Aug. 2000 Geliefert am 25. Aug. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility (as defined) | |
Kurze Angaben Land/blds at 35 king st,leicester; t/no LT152907; the goodwill of business and benefit of licences,as defined, and the benefits thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Feb. 2000 Geliefert am 23. Feb. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility (as defined) | |
Kurze Angaben Land at offley hill service,great offley, hertfordshire t/no.HD214419.by way of assignment the goodwill of the business carried on by the company, the benefit of the licences and the benefits (both as defined).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge by way of legal mortgage and floating charge over assets | Erstellt am 04. Jan. 2000 Geliefert am 18. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or courtenay developments limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 39 and 41 silver street t/no;-EX464704 and land adjoining 41 silver street stansted essex and land situate adjacent to and to the rear of 43 silver street stansted together with all buildings fixtures fixed plant and machinery from time to time thereon and by way of first floating charge the assets of the mortgagor both present and future on the property from time to time including all equipment machinery materials and other chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Jan. 2000 Geliefert am 18. Jan. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag Overage payments (if any) due from the company and/or courtenay developments limited to the chargee under the terms of an agreement dated 29TH october 1999 | |
Kurze Angaben F/H property k/a 39 and 41 silver street and land adjoining 41 silver street stanstead essex t/no;-EX464704 and land situate adjacent to the rear of 43 silver street stanstead. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at westbury farm great offley hitchin hertfordshire and the goodwill of the business and the benefit of licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0