ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED

ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02917485
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Connexions
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ENTERPRISE PROPERTY GROUP LIMITED07. Sept. 200707. Sept. 2007
    ASHTENNE RESIDENTIAL LIMITED10. Jan. 199610. Jan. 1996
    ELLINGWELL LIMITED11. Apr. 199411. Apr. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Dez. 2022
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am01. Dez. 2023
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. Aug. 2024
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung14. Sept. 2024
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. Aug. 2023
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2026

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Jan. 2025

    17 SeitenLIQ03

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    5 SeitenNDISC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Scutches Barn 17 High Street Whittlesford Cambridge CB22 4LT England zum Connexions 159 Princes Street Ipswich IP1 1QJ am 15. Jan. 2024

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Jan. 2024

    LRESEX

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Beendigung der Bestellung von Robert James Morell Keatley als Geschäftsführer am 20. Dez. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Dominic Henry Johnstone White als Geschäftsführer am 20. Dez. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Charles Micklethwaite als Geschäftsführer am 18. Dez. 2023

    1 SeitenTM01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Peter Robert Stocking als Geschäftsführer am 30. Sept. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Simon John Brown als Geschäftsführer am 30. Sept. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Simon Brown als Sekretär am 30. Sept. 2023

    1 SeitenTM02

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2022 bis 30. Dez. 2022

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Katy Sarah Jordan als Geschäftsführer am 19. Apr. 2023

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Brown als Sekretär am 09. März 2023

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Marilyn Ann Gibb-Rice als Sekretär am 09. März 2023

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Katy Sarah Jordan als Direktor am 17. Okt. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Katy Sarah Jordan als Geschäftsführer am 17. Okt. 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Katy Sarah Jordan als Direktor am 17. Okt. 2022

    2 SeitenAP01

    Eintragung der Belastung 029174850015, erstellt am 11. Okt. 2022

    27 SeitenMR01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    26 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVISON, Neil John
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Connexions
    Geschäftsführer
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Connexions
    EnglandBritish39292900013
    BROWN, Simon
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Sekretär
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    306502990001
    BROWN, Simon John
    Beckbrook Equestrian Centre
    Oakington Road Girton
    CB3 0QH Cambridge
    Sekretär
    Beckbrook Equestrian Centre
    Oakington Road Girton
    CB3 0QH Cambridge
    British72693260002
    DAVISON, Neil John
    Church House
    Church Lane
    CB1 6PL Bartlow
    Cambridgeshire
    Sekretär
    Church House
    Church Lane
    CB1 6PL Bartlow
    Cambridgeshire
    British39292900002
    GIBB-RICE, Marilyn Ann
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Sekretär
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    248650910001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    BROWN, Simon John
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    United KingdomBritish72693260002
    JONES, Morgan Lewis
    First Street
    SW3 2LB London
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    First Street
    SW3 2LB London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish10146340004
    JORDAN, Katy Sarah
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish301408910001
    JORDAN, Katy Sarah
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish209957990001
    KEATLEY, John Rankin Macdonald
    Melbourn Lodge
    SG8 6AL Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Melbourn Lodge
    SG8 6AL Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritish23509620001
    KEATLEY, Robert James Morell
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    United KingdomBritish94753520002
    MICKLETHWAITE, Christopher Charles
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish50904570003
    MICKLETHWAITE, Christopher Charles
    Friars Elm Dogkennel Green
    Ranmore
    RH5 6SU Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Friars Elm Dogkennel Green
    Ranmore
    RH5 6SU Dorking
    Surrey
    EnglandBritish50904570002
    MORRISON, Gordon
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    EnglandBritish1087030003
    STOCKING, Peter Robert
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish69569450003
    WATSON, Ian Richard
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish68256540001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WHITE, Anthony Johnstone
    Workham Farm
    Fifield
    OX7 6HS Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Workham Farm
    Fifield
    OX7 6HS Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish1674470001
    WHITE, Dominic Henry Johnstone
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Geschäftsführer
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    EnglandBritish70488140005
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Enterprise Property Group Limited
    High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    27. Apr. 2018
    High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Neil John Davison
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    06. Apr. 2016
    17 High Street
    Whittlesford
    CB22 4LT Cambridge
    Scutches Barn
    England
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 11. Okt. 2022
    Geliefert am 17. Okt. 2022
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All the chargor's share of and interest now or hereafter subsisting ("the relevant interest") in railway square (chelmsford) LLP including: (a) all distributions, profit shares, interests and bonuses and other income arising out of or accruing in respect of the relevant interest; and (b) all voting and other rights, powers, privileges and other benefits conferred by the relevant interest.. For more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Paragon Development Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2022Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Apr. 2022
    Geliefert am 25. Apr. 2022
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All the chargor’s share of and interest now or hereafter subsisting (“the relevant interest”) in high street (harston) LLP, a limited liability partnership incorporated in england and wales whose registered office is scutches barn, 17 high street, whittlesford, cambs, CB22. 4LT (“the LLP”) including:. (A) all distributions, profit shares, interests and bonuses and other income arising. Out of or accruing in respect of the relevant interest; and. (B) all voting and other rights, powers. For more details of the assets charged please refer to the instrument.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Paragon Development Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2022Registrierung einer Belastung (MR01)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Nov. 2008
    Geliefert am 21. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower or the company or enterprise to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its partnership interest and its related rights meaning all distributions, all assets and rights derived from, incidental to or offered in exchange for, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Nov. 2008
    Geliefert am 07. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £442,000 due or to become due
    Kurze Angaben
    Crossroads, water lane, helions bumpstead, halstead, essex.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Nov. 2002
    Geliefert am 20. Nov. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at lower farm barley herts. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Feb. 2002
    Geliefert am 21. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south of meadow way great offley hitchin. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 2002
    Geliefert am 02. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The former rectory market place kettering northamptonshire and garden ground t/n-NN219496. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge between the company and enterprise heritage capital limited trading together as the enterprise heritage development partnership ("the mortgagor")(1) the bank (2)
    Erstellt am 02. Nov. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the legal charge
    Kurze Angaben
    All that land adjoining 49 market hill, maldon with all buildings and erections thereon and all fixtures and fittings therein and all services and means of access. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Heritable Bank Limited
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    A charge over cash between the company and enterprise heritage capital limited together as the enterprise heritage development partnership (the customer) and the chargee
    Erstellt am 18. Aug. 2000
    Geliefert am 23. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any account of the customer held by the bank as referred to in facility letter dated 9TH august 2000 addressed from the bank to the customer and any agreement or letter amending supplementing or replacing the same.
    Berechtigte Personen
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    A legal charge between the company and enterprise heritable capital limited trading together as the enterprise heritage development partnership and the chargee
    Erstellt am 18. Aug. 2000
    Geliefert am 23. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 33 and 35 market hill maldon - EX634204 ; f/h property k/a 37 market hill maldon - ex 634203 ; f/h property k/a land on the west side of market hill maldon - EX476477 (see M395 for other properties) and including all buildings and erections thereon and all services and means of access and egress thereto and therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Heritable and General Investment Bank Limited
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Aug. 2000
    Geliefert am 25. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility (as defined)
    Kurze Angaben
    Land/blds at 35 king st,leicester; t/no LT152907; the goodwill of business and benefit of licences,as defined, and the benefits thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 2000
    Geliefert am 23. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility (as defined)
    Kurze Angaben
    Land at offley hill service,great offley, hertfordshire t/no.HD214419.by way of assignment the goodwill of the business carried on by the company, the benefit of the licences and the benefits (both as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Charge by way of legal mortgage and floating charge over assets
    Erstellt am 04. Jan. 2000
    Geliefert am 18. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or courtenay developments limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    39 and 41 silver street t/no;-EX464704 and land adjoining 41 silver street stansted essex and land situate adjacent to and to the rear of 43 silver street stansted together with all buildings fixtures fixed plant and machinery from time to time thereon and by way of first floating charge the assets of the mortgagor both present and future on the property from time to time including all equipment machinery materials and other chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Jan. 2000
    Geliefert am 18. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Overage payments (if any) due from the company and/or courtenay developments limited to the chargee under the terms of an agreement dated 29TH october 1999
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 39 and 41 silver street and land adjoining 41 silver street stanstead essex t/no;-EX464704 and land situate adjacent to the rear of 43 silver street stanstead. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Harman James Hagon
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 1999
    Geliefert am 25. März 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at westbury farm great offley hitchin hertfordshire and the goodwill of the business and the benefit of licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 25. März 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ENTERPRISE RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Jan. 2024Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Paul Scrivener
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Praktiker
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Mark Upton
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Suffolk
    Praktiker
    159 Princes Street
    IP1 1QJ Ipswich
    Suffolk

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0