ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02918390
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Portwall Place
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY PLC10. Aug. 199410. Aug. 1994
    WATCHSAVE PUBLIC LIMITED COMPANY13. Apr. 199413. Apr. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Okt. 2013

    14 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Okt. 2012

    LRESSP

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 04. Sept. 2012

    • Kapital: GBP 0.25
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 32 Ludgate Hill London EC4M 7DR am 08. März 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    22 SeitenAA

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt

    2 SeitenAD04

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    20 SeitenAR01

    Ernennung von Praxis Fund Services Limited als Sekretär

    3 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Bharat Bhagani als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von George Robb als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Hugh Tilney als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Barry Aling als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charles Wilkinson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Geoffrey Richard Miller als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Patrick Firth als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beschlüsse

    Resolutions
    30 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    45 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PRAXIS FUND SERVICES LIMITED
    Le Truchot
    GY1 4NA St Peter Port
    Sarnia House
    Guernsey
    Sekretär
    Le Truchot
    GY1 4NA St Peter Port
    Sarnia House
    Guernsey
    RechtsformLIMITED COMPANY
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageGUERNSEY
    Registrierungsnummer43046
    161725640001
    FIRTH, Patrick
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Avon
    Geschäftsführer
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Avon
    GuernseyBritish161723600001
    MILLER, Geoffrey Richard
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Avon
    Geschäftsführer
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Avon
    GuernseyBritish161723850001
    BHAGANI, Bharat
    2 Holly Avenue
    HA7 1EZ Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    2 Holly Avenue
    HA7 1EZ Stanmore
    Middlesex
    British114377680001
    BUCKLEY, David Charles
    Homestead Woodland Way
    Kingswood
    KT20 6PA Tadworth
    Surrey
    Sekretär
    Homestead Woodland Way
    Kingswood
    KT20 6PA Tadworth
    Surrey
    British101130710001
    CORBO, Alessio
    55 Fortis Green
    East Finchley
    N2 9JJ London
    Sekretär
    55 Fortis Green
    East Finchley
    N2 9JJ London
    Italian91372970001
    CORBO, Alessio
    55 Fortis Green
    East Finchley
    N2 9JJ London
    Sekretär
    55 Fortis Green
    East Finchley
    N2 9JJ London
    Italian91372970001
    CRICKMORE, Nicola Jane
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    Sekretär
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    British115328860001
    JENNINGS, Paul William
    65 Station Road
    HP7 0BB Amersham
    Buckinghamshire
    Sekretär
    65 Station Road
    HP7 0BB Amersham
    Buckinghamshire
    United Kingdom63572730001
    PRITCHARD, Michael Andrew
    42b Putney High Street
    SW15 1SQ London
    Sekretär
    42b Putney High Street
    SW15 1SQ London
    British100475760001
    MACINTYRE HUDSON PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
    Moorgate House 201 Silbury Boulevard
    Central Milton Keynes
    MK9 1LZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Moorgate House 201 Silbury Boulevard
    Central Milton Keynes
    MK9 1LZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    40720500001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    Sekretär
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    75423270001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALING, Barry Alan
    The Orangery
    Penshurst Road
    TN11 8HY Penshurst
    Kent
    Geschäftsführer
    The Orangery
    Penshurst Road
    TN11 8HY Penshurst
    Kent
    EnglandBritish98355070002
    BOWDEN, Adrian Harold Houston
    33 Grosvenor Square
    W1X 9LL London
    Geschäftsführer
    33 Grosvenor Square
    W1X 9LL London
    British28915500001
    BRIDGEMAN, Robin John Orlando
    19 Chepstow Road
    W2 5BP London
    Geschäftsführer
    19 Chepstow Road
    W2 5BP London
    EnglandBritish5943640001
    MARTIN-CLARK, David Lindsay
    26 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    Geschäftsführer
    26 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    EnglandBritish17155750001
    MILLER, Geoffrey Richard
    Beccles Road
    Loddon
    NR14 6JQ Norwich
    6
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Beccles Road
    Loddon
    NR14 6JQ Norwich
    6
    Norfolk
    British107180660002
    RIDDELL, Norman Malcolm Marshall
    Long Bar
    Little Hallingbury
    CM22 7QU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Long Bar
    Little Hallingbury
    CM22 7QU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish688250001
    ROBB, George Alan
    The Street
    RH14 0PT Plaistow
    The Tile House
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Street
    RH14 0PT Plaistow
    The Tile House
    West Sussex
    EnglandEnglish35558670006
    ROBB, George Alan
    The Cedars
    Compton Way
    GU10 1QY Moor Park Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cedars
    Compton Way
    GU10 1QY Moor Park Farnham
    Surrey
    British35558670005
    SPURDLE, John William
    333 East 68th Street Apt 9d
    FOREIGN New York
    10021
    Usa
    Geschäftsführer
    333 East 68th Street Apt 9d
    FOREIGN New York
    10021
    Usa
    British73505270001
    TAYLOR, John R
    45 East 89th Street, Apt 40e,
    New York
    New York 10128
    Usa
    Geschäftsführer
    45 East 89th Street, Apt 40e,
    New York
    New York 10128
    Usa
    American106053350001
    THOMSON, Frederick Douglas David, Sir
    Holylee
    EH43 6BD Walkerburn
    Peeblesshire
    Geschäftsführer
    Holylee
    EH43 6BD Walkerburn
    Peeblesshire
    ScotlandBritish40548660001
    TILNEY, Hugh James
    439 East 51st Street
    New York
    Ny 10022
    Usa
    Geschäftsführer
    439 East 51st Street
    New York
    Ny 10022
    Usa
    United StatesBritish111019350001
    WARD, Hugh Roderick
    Sunset Lodge
    La Rue De Haute
    JE3 8AR St Brelade
    Jersey
    Geschäftsführer
    Sunset Lodge
    La Rue De Haute
    JE3 8AR St Brelade
    Jersey
    JerseyBritish89956550001
    WILKINSON, Charles Edmund
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    GuernseyBritish127529840001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Hat ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Feb. 2011
    Geliefert am 05. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 13. Sept. 2006
    Geliefert am 22. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 25. März 2004
    Geliefert am 03. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charged account being the account (denominated in whatever currency) of the company with the bank, which account is blocked or designated as charged to bos and is now numbered 05228USD02 as the same may be replaced, redesignated, renumbered or rearranged from time to time and the deposit being the sum of us$4,400,000 together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the charged account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juli 2000
    Geliefert am 15. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage of securities
    Erstellt am 30. Juli 1999
    Geliefert am 06. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 28 july 1999
    Kurze Angaben
    £500,000 nominal UK gilt 6% treasury stock maturing 100899 £590,000 nominal UK gilt 10.5% conversion stock maturing 221199. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert Fleming & Co.Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage over securities
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 03. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee and as a continuing security for the discharge in full of the obligations secured by the charge:- 1. charges and agrees to mortgage to the bank the securities; and 2. assigns to the bank by way of security the account rights and all of the company's rights against dunlaw nominees limited, the bank's nominee.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Duncan Lawrie Limited
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of pledge
    Erstellt am 06. Juni 1996
    Geliefert am 18. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All stocks shares bonds debentures or other deposits held by the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Okt. 2012Beginn der Liquidation
    16. Jan. 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gilbert J Lemon
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Praktiker
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Paul David Wood
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Praktiker
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0