CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02919329 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Adsetts House 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
KEELEX 183 LIMITED | 15. Apr. 1994 | 15. Apr. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Aug. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kulbinder Kaur Dosanjh als Geschäftsführer am 31. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Watkins als Direktor am 31. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kulbinder Kaur Dosanjh als Sekretär am 31. März 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Kulbinder Kaur Dosanjh am 22. Dez. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Cessation of Capco Uk Holdings Limited as a person with significant control on 22. Dez. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Sig Building Products Limited as a person with significant control on 22. Dez. 2020 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 31. Dez. 2019 | 9 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Charles Monro als Geschäftsführer am 18. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Kulbinder Kaur Dosanjh als Sekretär am 18. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Ms Kulbinder Kaur Dosanjh als Direktor am 18. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Charles Monro als Sekretär am 18. Okt. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKSON, Ian | Geschäftsführer | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 186473820002 | ||||
WATKINS, Andrew | Geschäftsführer | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | England | British | Group General Counsel & Company Secretary | 281612300001 | ||||
CRAIG, Brian Mervyn | Sekretär | Colhugh Kilmore Avenue Killiney Co Dublin Ireland | Irish | Director | 21764630001 | |||||
DOSANJH, Kulbinder Kaur | Sekretär | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | 264041310001 | |||||||
FARRELL, John Patrick | Sekretär | Broadcroft Little Hallingbury CM22 7RT Bishops Stortford Herts | British | Director | 702300001 | |||||
GREATRIX, Jenny | Sekretär | 23 Thompson Road WS15 1HW Rugeley Staffordshire | British | 34581620001 | ||||||
MONRO, Richard Charles | Sekretär | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | British | 59480370001 | ||||||
SWYNNERTON, John Ralph | Sekretär | 30 Bents Road S11 9RJ Sheffield South Yorkshire | British | 2646260001 | ||||||
APPLETON, George | Geschäftsführer | 21 New Garden Street ST17 4DB Stafford Staffordshire | British | Executive Director | 79234540001 | |||||
CRAIG, Brian Mervyn | Geschäftsführer | Colhugh Kilmore Avenue Killiney Co Dublin Ireland | Irish | Director | 21764630001 | |||||
DAVIES, Gareth Wyn | Geschäftsführer | Creskeld Valley House 43 Hall Drive Bramhope LS16 9JF Leeds West Yorkshire | England | British | Finance Director | 109674760001 | ||||
DOSANJH, Kulbinder Kaur | Geschäftsführer | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 231199720003 | ||||
FARRELL, John Patrick | Geschäftsführer | Broadcroft Little Hallingbury CM22 7RT Bishops Stortford Herts | United Kingdom | British | Director | 702300001 | ||||
FOTHERINGHAM, Colin George Ewing | Geschäftsführer | Pond View Drain Lane Holme On Spalding Moor YO43 4DQ York East Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 82642480001 | ||||
GLACKIN, Paul | Geschäftsführer | 14 Arnold Way OX9 2QA Thame Oxfordshire | United Kingdom | British | Managing Director | 40194020001 | ||||
GOLESTANI, Kian | Geschäftsführer | 2 Hawkesmoor Drive WS14 9YH Lichfield Staffordshire | British | Solicitor | 46764350001 | |||||
HAYDEN, Terence James | Geschäftsführer | St Margarets Cross Avenue Blackrock County Dublin Eire | Irish | Non Executive Director | 40194050001 | |||||
MONRO, Richard Charles | Geschäftsführer | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 59480370001 | ||||
PRUST, Francis Charles | Geschäftsführer | Peverill 25 Wharfe Bank LS22 5JP Collingham West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 54280001 | |||||
ROE, Darren | Geschäftsführer | 17 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Signet House United Kingdom | England | British | Accountant | 106708580001 | ||||
WILLIAMS, David | Geschäftsführer | 48 Wood Lane Wickersley S66 1JX Rotherham "Merrymede" South Yorkshire | England | English | Managing Director | 127986830001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sig Building Products Limited | 22. Dez. 2020 | Ballymount Retail Centre Ballymount Road Lower Dublin Sig House Dublin Ireland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Capco Uk Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 16 Europa View Sheffield Business Park S9 1XH Sheffield Adsetts House United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CAPCO INTERIOR SUPPLIES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 25. Okt. 1995 Geliefert am 13. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 20. Okt. 1994 Geliefert am 09. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0