DRIVEMASTER LEASE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDRIVEMASTER LEASE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02921721
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DRIVEMASTER LEASE LIMITED?

    • (6321) /

    Wo befindet sich DRIVEMASTER LEASE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cartwright House
    Tottle Road
    NG2 1RT Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DRIVEMASTER LEASE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROSS VEHICLE LEASING LTD.16. Apr. 199616. Apr. 1996
    SCAN-GB LIMITED24. Mai 199424. Mai 1994
    SCORCHERS LIMITED22. Apr. 199422. Apr. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DRIVEMASTER LEASE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für DRIVEMASTER LEASE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Feb. 2011

    5 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    9 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Aug. 2009

    14 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    8 Seiten2.16B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    1 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    19 Seiten2.17B

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    11 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten88(2)

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Allotment of shares 28/03/2008
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von DRIVEMASTER LEASE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KPP INVESTMENTS LIMITED
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    126325510001
    ARMSTRONG, Louis
    44 Knightsbridge Way
    Stretton
    DE13 0WJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    44 Knightsbridge Way
    Stretton
    DE13 0WJ Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishEngineer89428890001
    CROSS, Jeremy Andrew
    The Bakehouse
    Station Road
    DE13 9AA Rolleston
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Bakehouse
    Station Road
    DE13 9AA Rolleston
    Staffordshire
    BritishConsultant127707600001
    CROSS, Katherine Emma
    Bell House Farm
    Bell House Lane
    DE13 9PA Anslow Burton
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bell House Farm
    Bell House Lane
    DE13 9PA Anslow Burton
    Staffordshire
    United KingdomBritishHr Manager88681620001
    PEARSON, Kevin Paul
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishConsultant65782050001
    BASKERVILLE, Wendy
    Lower Marshay
    Pennymoor
    EX16 8LZ Tiverton
    Devon
    Sekretär
    Lower Marshay
    Pennymoor
    EX16 8LZ Tiverton
    Devon
    British39403470001
    CROSS, Betty Anne
    41 Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    41 Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    Staffordshire
    British37780910001
    MARKHAM, Geoffrey John
    Longwater Cross Longwater Road
    Finchampstead
    RG40 3TS Wokingham
    Berkshire
    Sekretär
    Longwater Cross Longwater Road
    Finchampstead
    RG40 3TS Wokingham
    Berkshire
    English62856730001
    PEARSON, Kevin Paul
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    British65782050001
    RODELL, John
    21 Windsor Road
    Durrington
    SP4 8AA Salisbury
    Wiltshire
    Sekretär
    21 Windsor Road
    Durrington
    SP4 8AA Salisbury
    Wiltshire
    British52951010001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    ARMSTRONG, Louis
    44 Knightsbridge Way
    Stretton
    DE13 0WJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    44 Knightsbridge Way
    Stretton
    DE13 0WJ Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishEngineer89428890001
    BASKERVILLE, Alan
    Lower Marhay
    Pennymoor
    EX16 8LZ Tiverton
    Devon
    Geschäftsführer
    Lower Marhay
    Pennymoor
    EX16 8LZ Tiverton
    Devon
    BritishCompany Director39403610001
    CROSS, Granville Albert
    41 Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    41 Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishDirector37780950001
    CROSS, Jeremy Andrew
    The Bakehouse
    Station Road
    DE13 9AA Rolleston
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Bakehouse
    Station Road
    DE13 9AA Rolleston
    Staffordshire
    BritishDirector127707600001
    MARTIN, Stephen Roy
    11 Ploughmans Place
    Roughley Four Oaks
    B75 5TR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    11 Ploughmans Place
    Roughley Four Oaks
    B75 5TR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishConsultant74713060002
    PEARSON, Kevin Paul
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    210a Henhurst Hill
    DE13 9SU Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishConsultant65782050001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat DRIVEMASTER LEASE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge
    Erstellt am 31. Dez. 2007
    Geliefert am 16. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First specific equitable charge over all contracts of lease or hire in relation to all or any goods acquired with all monies payable thereunder and any proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC T/as Allied Irish Bank (GB)
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. Mai 2006
    Geliefert am 15. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Monies due to the company under the rental agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paccar Financial Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    First fixed charge
    Erstellt am 28. Nov. 2005
    Geliefert am 13. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all sub-lease agreements, all moneys payable under the sub-lease agreements, the benefit of all guarantees, insurance,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mercedes-Benz Charterway Limited
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Master assignment
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC a&L Cf March (2) Limited a&L Cf June (1) Limitedfor Further Details of Chargees Please Refer Toform 395
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 01/09/05
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. Apr. 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat DRIVEMASTER LEASE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Feb. 2010Ende der Verwaltung
    24. Feb. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alistair Steven Wood
    Mazars
    Cartwright House
    NG2 1RT Tottle Road
    Nottingham
    Praktiker
    Mazars
    Cartwright House
    NG2 1RT Tottle Road
    Nottingham
    Philip Michael Lyon
    Mazars Llp Cartwright House
    Tottle Road
    NG2 1RT Nottingham
    Praktiker
    Mazars Llp Cartwright House
    Tottle Road
    NG2 1RT Nottingham
    2
    DatumTyp
    16. Aug. 2011Aufgelöst am
    12. Feb. 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alistair Steven Wood
    Mazars
    Cartwright House
    NG2 1RT Tottle Road
    Nottingham
    Praktiker
    Mazars
    Cartwright House
    NG2 1RT Tottle Road
    Nottingham
    Philip Michael Lyon
    Mazars Llp Cartwright House
    Tottle Road
    NG2 1RT Nottingham
    Praktiker
    Mazars Llp Cartwright House
    Tottle Road
    NG2 1RT Nottingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0