VOYAGE HEALTHCARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VOYAGE HEALTHCARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02925614 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Voyage Care Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PARAGON HEALTHCARE LIMITED | 15. Apr. 2003 | 15. Apr. 2003 |
| MILBURY COMMUNITY LIMITED | 22. Juli 1994 | 22. Juli 1994 |
| BROOMCO (763) LIMITED | 04. Mai 1994 | 04. Mai 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 31. März 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Philip Andre Sealey als Direktor am 09. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Wei Roberts als Geschäftsführer am 09. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD* am 22. Nov. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Kevin Wei Roberts als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Mckendrick als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 29 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Winning als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Moreton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VOYAGE HEALTHCARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEALEY, Philip Andre | Sekretär | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | British | 45325360001 | ||||||
| SEALEY, Philip Andre | Geschäftsführer | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire | England | British | 45325360001 | |||||
| WINNING, Andrew | Geschäftsführer | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | England | British | 73772160002 | |||||
| BERRY, Philip Thomas | Sekretär | 41 Rosewood Park Rosewood Court WS6 7HD Cheslyn Hay Staffordshire | British | 47529490001 | ||||||
| MORETON, Nigel Keef | Sekretär | Swan Farm Mill Lane WS9 9HN Lower Stonnall Staffordshire | British | 57063050002 | ||||||
| SEALEY, Philip Andre | Sekretär | 4 Beoley Hall Icknield St Beoley B98 9AL Redditch Worcestershire | British | 45325360001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| BERRY, Philip Thomas | Geschäftsführer | 3 Roman Grange B74 3GA Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 47529490002 | |||||
| BROCK, Julian Richard Christopher | Geschäftsführer | Haredell Martinsend Lane HP16 9HR Great Missenden Buckinghamshire | British | 74294460003 | ||||||
| HARRIS, Nigel Robert | Geschäftsführer | Cedar Cottage Croft Lane, Crondall GU10 5QG Farnham Surrey | British | 16250270002 | ||||||
| MCKENDRICK, James Bruce | Geschäftsführer | Garrick House 2 Queen Street WS13 6QD Lichfield Staffordshire | England | British | 154043480001 | |||||
| MILESTONE, Neill Frederick, Mr. | Geschäftsführer | Lysways Hall Lysways Lane WS15 4QB Longdon Green Staffordshire | England | British | 13850080002 | |||||
| MORETON, Nigel Keef | Geschäftsführer | Garrick House 2 Queen Street WS13 6QD Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | 57063050002 | |||||
| QUINN, Douglas John | Geschäftsführer | Garrick House 2 Queen Street WS13 6QD Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | 80757840002 | |||||
| ROBERTS, Kevin Wei | Geschäftsführer | Wall Island Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Voyage Care Staffordshire England | England | British | 72030660002 | |||||
| SMITH, Andrew Colwyn | Geschäftsführer | 5 Foden Close Shenstone WS14 0LE Litchfield Staffordshire | British | 78023740001 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Hat VOYAGE HEALTHCARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed | Erstellt am 03. Apr. 2013 Geliefert am 08. Apr. 2013 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 04. Apr. 2006 Geliefert am 20. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 02. Juli 2004 Geliefert am 09. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party and any investor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Property including: the woodlnds, church lane, acklam, t/no CE8507, belchford, hesledon road, blackhall, t/no DU110208, 336 cowpen road, blyth, t/no ND117576 and for further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Sept. 2001 Geliefert am 14. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company and/or each other charging company (except for sums owed by such company in it's capacity as a guarantor for the chargor) to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1994 Geliefert am 15. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0