KENTCO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKENTCO LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02925662
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KENTCO LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich KENTCO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Enterprise House
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KENTCO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LOMBARD STREET PROPERTIES (CANTERBURY) LIMITED27. Dez. 199627. Dez. 1996
    LOMBARD STREET PROPERTIES (IPSWICH) LIMITED27. Nov. 199527. Nov. 1995
    LOMBARD STREET PROPERTIES (ASHFORD) LIMITED21. Juli 199421. Juli 1994
    BROOMCO (779) LIMITED04. Mai 199404. Mai 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KENTCO LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Aug. 2010
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Mai 2011
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2009

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für KENTCO LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis04. Mai 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung18. Mai 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KENTCO LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für KENTCO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Beendigung der Bestellung von Stuart Roy Dixon als Sekretär am 01. März 2017

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David Longworth Birchenall als Geschäftsführer am 06. Feb. 2017

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Mai 2016

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Nov. 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Mai 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 07. Nov. 2014

    2 Seiten3.6

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    10 SeitenRM01

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    1 SeitenRM02

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Christopher Hancock als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Little Westwood Farm Bucks Hill Kings Langley Hertfordshire WD4 9AR United Kingdom* am 14. Juli 2011

    1 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Ernennung von Mr Stuart Roy Dixon als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 05. Mai 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Mr Christopher Hancock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Portland House, Stag Place Bressenden Place London SW1E 5RS United Kingdom* am 07. Okt. 2010

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Stuart Dixon als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 24 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH United Kingdom* am 29. Juli 2010

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von KENTCO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DIXON, Stuart Roy
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    Sekretär
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    159847750001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Sekretär
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    BritishProject Manager27616940001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BIRCH, Sally Ann
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishSecretary123289480001
    BIRCHENALL, David Longworth
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    Geschäftsführer
    21 Buckle Street
    E1 8NN London
    Enterprise House
    United KingdomBritishDirector118115050001
    DIXON, Stuart Roy
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House, Stag Place
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bressenden Place
    SW1E 5RS London
    Portland House, Stag Place
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant56735900001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    EnglandBritishProject Manager27616940001
    HANCOCK, Christopher
    Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Kynnersley
    England
    Geschäftsführer
    Park Road
    Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Kynnersley
    England
    EnglandBritishSurveyor87069290001
    LAWRENCE, Angela Rosemary
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishPrivate Secretary27616950001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Hat KENTCO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 and f/h property k/a 29 gallowtree gate and 65/69 market place and 1 3 and 5 victoria parade t/no's LT297194 LT13323 LT34591 and LT18286. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 304. Dez. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 311. Juli 2017Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 3
    Deed of assignment
    Erstellt am 30. Jan. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest under the leases in respect of f/h property k/a 49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 and f/h property k/a 29 gallowtree gate and 65/69 market place and 1 3 and 5 victoria parade t/no's LT297194 LT13323 LT34591 and LT18286. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 106. Juli 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 123. Nov. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Second legal charge
    Erstellt am 30. Jan. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,520,000 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    49/51 gallowtree gate leicester t/no LT42533 and LT2133 65 67 69 market place 29 gallowtree gate and 1 3 and 5 victoria parade leicester t/no's LT18286 LT13323 LT34591 and LT297194.
    Berechtigte Personen
    • Dawnay Day Property Equity Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2008
    • 24. Dez. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture (floating charge)
    Erstellt am 01. März 2002
    Geliefert am 08. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A first floating charge all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 08. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 2002
    Geliefert am 08. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold land k/a 28 high street canterbury kent t/n K797851 and freehold landbeing 28 and 29 high street canterbury K. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 08. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of yearly rents
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 24. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under the terms of an agreement constituted by a facility letter dated 13 october 1997 the assignment or any other related security document (as defined) or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The company's right,title and interest in and to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the existing leases of the land and premises k/a 28/29 high street and 2/5 stour street canterbury kent and any leases of such land and premises or any part thereof subsequently granted within 21 years of the assignment.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over construction contract
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 24. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under the terms of a facility agreement dated 13 october 1997 this deed or any related security document
    Kurze Angaben
    "The contract" shall herein mean a construction contract dated 12 december 1997 for the development of 28/29 high street canterbury kent together with any bond issued pursuant thereto.the company's present and future rights,title and interest in and to the contract.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General security assignment
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 24. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    "The contract" shall herein mean an agreement for the grant of a lease of the ground and first floor premises at 29 high street canterbury kent.the benefit of the company's right,title and interest in and to the contract.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set off
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 24. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The monies now or hereafter to be standing to the credit of any account of the company at the bank.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 1997
    Geliefert am 24. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 29 high street canterbury kent.t/no.K287165.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 12. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £250,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The land to be comprised in the title number referred to in the charge including the buildings on the land k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • James Bruce Lee Palmer
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of yearly rents
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 12. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined) to the chargee under or pursuant to the terms of an agreement constituted by a facility letter dated 12TH february 1997, the assignment or any other related security document (as defined) or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys right title and interest in and to the clear yearly rents reserved or to be reserved by the existing leases of the land and premises situate and k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 12. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property and the buildings thereon k/a 28 high street and 2-5 stour street canterbury kent and all those buildings at first floor level and above adjoining the property first referred to but excluding the ground or roadway and those buildings at first floor level including all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 12. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable mortgage
    Erstellt am 19. Feb. 1997
    Geliefert am 08. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £125,000.00 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The contract dated 17/2/97 and any deeds and documents for the purchase of further interests in 28 high street, canterbury, kent and the full benefit thereof and the equitable interest of the company in the property.
    Berechtigte Personen
    • James Bruce Lee Palmer
    Transaktionen
    • 08. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat KENTCO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    J Green
    Elliott House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    Receiver Manager
    Elliott House 28a Devonshire Street
    W1G 6PS London
    2
    DatumTyp
    05. Juli 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robin Hamilton Davis
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    Praktiker
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    Melvyn Julian Carter
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    Praktiker
    Carter Backer Winter
    Enterprise House
    E1 8NN 21 Buckle Street
    London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jemma Kathleen Mcandrew
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Receiver Manager
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Richard James Stanley
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London
    Receiver Manager
    22 Hanover Square
    W1S 1JA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0