N & D SOUTHERN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameN & D SOUTHERN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02929134
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von N & D SOUTHERN LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich N & D SOUTHERN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von N & D SOUTHERN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INFOBEST LIMITED16. Mai 199416. Mai 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von N & D SOUTHERN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für N & D SOUTHERN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Mark Fletcher Jopling als Geschäftsführer am 20. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Nov. 2016

    4 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Peter On als Geschäftsführer am 25. Juli 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Helen Christine Gordon als Geschäftsführer am 24. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    6 SeitenAA

    Ernennung von Adam Mcghin als Sekretär am 04. März 2016

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Michael Patrick Windle als Sekretär am 04. März 2016

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Andrew Rolland Cunningham als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Helen Christine Gordon als Direktor am 31. Dez. 2015

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Greenwood als Geschäftsführer am 22. Dez. 2015

    2 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Citygate Saint James Boulevard Newcastle upon Tyne NE1 4JE zum 15 Canada Square London E14 5GL am 18. Dez. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 01. Dez. 2015

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 23. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Jeremy Robson am 06. Mai 2015

    3 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von N & D SOUTHERN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCGHIN, Adam
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    206242810001
    ROBSON, Mark Jeremy
    Albury Park Road
    NE30 2SH Tynemouth
    12
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Albury Park Road
    NE30 2SH Tynemouth
    12
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish97977930003
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Sekretär
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Sekretär
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British3470530003
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Sekretär
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Sekretär
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Geschäftsführer
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    CRUMBLEY, Brian Aidan
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish8495220002
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish74581390003
    DAVIDSON, Emanuel Wolfe
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    Geschäftsführer
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    United KingdomBritish3470540001
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Geschäftsführer
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritish35563210002
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DICKINSON, Robert Henry
    Styford Hall
    NE43 7TX Stocksfield
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Styford Hall
    NE43 7TX Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritish1509850001
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Geschäftsführer
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish8256950001
    GORDON, Helen Christine
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish59902650001
    GREENWOOD, Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish154194730002
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Geschäftsführer
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritish3470530003
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish60099210004
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Geschäftsführer
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    ON, Nicholas Peter
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish135860930002
    PRATT, Andrew Michael
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    EnglandBritish123314130002
    ROSCOE, Antony David
    24 Hillcroft Crescent
    W5 2SQ London
    Geschäftsführer
    24 Hillcroft Crescent
    W5 2SQ London
    EnglandBritish52996620001
    SCHWERDT, Peter Christopher George
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish44923060004
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001
    YUDOLPH, Debra Rachel
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    Geschäftsführer
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    EnglandBritish105582680001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat N & D SOUTHERN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 30. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first floating charge all of the company's properties and all other assets both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 17. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental mortgage
    Erstellt am 27. Sept. 2002
    Geliefert am 10. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from grainger properties limited (the "borrower") and/or the company and/or any other subsidiary guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) f/hold land known as 8 trevor square,london SW7; t/no ngl 641847; (ii) f/hold land known as 24 trevor sq,london SW7; ngl 641845; (iii) f/hold land known as 31 trevor sq,london SW7 1DY; NGL641846; all mortgage,estates or interests in the properties listed and the proceeds of sale thereof with all buildings,trade and other fixtures,plant,machinery,vehicles,computers and other equipment thereon; the benefit of all leases,tenancies and licences and all rental income derived; all credit balances,deposits and cash; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bradford & Bingley PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental mortgage
    Erstellt am 30. März 2001
    Geliefert am 06. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company or any of the borrowers (as defined) and/or any other subsidiary gurarantor (as defined) to the agent and/or any of the lenders (as defined) under or in connection with the finance documents (as defined) or otherwise on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The mortgage dated 13 april 2000 (as defined) shall be read and construed as if the words "any borrower" was substituted for the words "the borrower" in the definition "the secured obligations" in clause 1.1 of the mortgage.. The mortgage shall read as if the following clause was inserted as a new clause numbered 1.2.7 of the mortgage.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bradford & Bingley PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Apr. 2000
    Geliefert am 27. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company and/or grainger properties limited to the chargee under the loan agreement dated 31 march 2000, other related documents or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 and 7 staveley gardens, londdon W4. AGL45207. F/h property k/a 69 st margarets way twickenham. T/no. MX436235. F/h property k/a 6 and 9 coronation terrace wokingham. T/no. BK252409. And the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures all plant machinery and other equipment. All rights and interest in the policies of insurance, the benefit of any leases. Floating charge the undertaking and all its property assets and rights present and future. For details of further properties charged please refer to form 395.
    Berechtigte Personen
    • Bradford & Bingley Building Society as Agent and Trustee for Itself and the Other Lenders
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 29. Nov. 1994
    Geliefert am 12. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1994
    Geliefert am 04. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that PR0PERTY k/a 143 church lane rickmansworth. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge with floating charge
    Erstellt am 23. Aug. 1994
    Geliefert am 24. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    50 alexandra rd richmond. 42 azof street london SE10. 55 brand street west greenwich SE10. And various other properties . floating charge over all undertaking property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat N & D SOUTHERN LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. März 2018Aufgelöst am
    01. Dez. 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0