N & D SOUTHERN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | N & D SOUTHERN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02929134 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von N & D SOUTHERN LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich N & D SOUTHERN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von N & D SOUTHERN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INFOBEST LIMITED | 16. Mai 1994 | 16. Mai 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von N & D SOUTHERN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für N & D SOUTHERN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Mark Fletcher Jopling als Geschäftsführer am 20. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Nov. 2016 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator | 30 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Peter On als Geschäftsführer am 25. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Christine Gordon als Geschäftsführer am 24. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Adam Mcghin als Sekretär am 04. März 2016 | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Patrick Windle als Sekretär am 04. März 2016 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Rolland Cunningham als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Helen Christine Gordon als Direktor am 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Greenwood als Geschäftsführer am 22. Dez. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Citygate Saint James Boulevard Newcastle upon Tyne NE1 4JE zum 15 Canada Square London E14 5GL am 18. Dez. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Jeremy Robson am 06. Mai 2015 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von N & D SOUTHERN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGHIN, Adam | Sekretär | Canada Square E14 5GL London 15 | 206242810001 | |||||||
| ROBSON, Mark Jeremy | Geschäftsführer | Albury Park Road NE30 2SH Tynemouth 12 Tyne & Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 97977930003 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Sekretär | 9 The Copse Burnopfield NE16 6HA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 65421150001 | ||||||
| GLANVILLE, Marie Louise | Sekretär | 28 Bramhall Drive High Generals Wood Rickleton NE38 9DB Washington Tyne & Wear | English | 86483290001 | ||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Sekretär | 80 Kingsley Way N2 0EN London | British | 3470530003 | ||||||
| MILBURN, Peter Michael | Sekretär | Derwent Lodge DH8 0TG Shotley Bridge County Durham | British | 36406380001 | ||||||
| WINDLE, Michael Patrick | Sekretär | Stanton Townhead NE65 8PR Morpeth High Priar Northumberland | British | 135308530001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| COUCH, Peter Quentin Patrick | Geschäftsführer | Amberley GL5 5AG Gloucestershire Follifoot House | Uk | British | 156117090001 | |||||
| CRUMBLEY, Brian Aidan | Geschäftsführer | 10 Westfield Grove Gosforth NE3 4YA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 8495220002 | |||||
| CUNNINGHAM, Andrew Rolland | Geschäftsführer | St James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | England | British | 74581390003 | |||||
| DAVIDSON, Emanuel Wolfe | Geschäftsführer | 6 Beechworth Close NW3 7UT London | United Kingdom | British | 3470540001 | |||||
| DAVIDSON, Gerald Abraham | Geschäftsführer | Gardnor House Flask Walk NW3 1HT London | United Kingdom | British | 35563210002 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Geschäftsführer | 17 Lintzford Road Hamsterley Mill Rowlands Gill NE39 1HA Newcastle Upon Tyne | England | British | 65421150003 | |||||
| DICKINSON, Robert Henry | Geschäftsführer | Styford Hall NE43 7TX Stocksfield Northumberland | United Kingdom | British | 1509850001 | |||||
| DICKINSON, Rupert Jerome | Geschäftsführer | 59 Albert Bridge Road SW11 4AQ London | United Kingdom | British | 60267600001 | |||||
| DICKINSON, Stephen | Geschäftsführer | Crow Hall NE47 7BJ Bardon Mill Northumberland | United Kingdom | British | 8256950001 | |||||
| GORDON, Helen Christine | Geschäftsführer | St James Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | England | British | 59902650001 | |||||
| GREENWOOD, Mark | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | British | 154194730002 | |||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Geschäftsführer | 80 Kingsley Way N2 0EN London | England | British | 3470530003 | |||||
| JOPLING, Nicholas Mark Fletcher | Geschäftsführer | St James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | United Kingdom | British | 60099210004 | |||||
| MILBURN, Peter Michael | Geschäftsführer | Derwent Lodge DH8 0TG Shotley Bridge County Durham | British | 36406380001 | ||||||
| ON, Nicholas Peter | Geschäftsführer | Saint James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | United Kingdom | British | 135860930002 | |||||
| PRATT, Andrew Michael | Geschäftsführer | Shadybrook, Beeches Drive Farnham Common SL2 3JT Slough Berkshire | England | British | 123314130002 | |||||
| ROSCOE, Antony David | Geschäftsführer | 24 Hillcroft Crescent W5 2SQ London | England | British | 52996620001 | |||||
| SCHWERDT, Peter Christopher George | Geschäftsführer | Newtown House Alton Barnes SN8 4LB Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | 44923060004 | |||||
| SLADE, Sean Anthony | Geschäftsführer | Idlewood Maidenhead Road SL6 9DF Cookham Berkshire | British | 94640230001 | ||||||
| YUDOLPH, Debra Rachel | Geschäftsführer | 43 Netheravon Road W4 2AN London | England | British | 105582680001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat N & D SOUTHERN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 30. Juni 2004 Geliefert am 17. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of a first floating charge all of the company's properties and all other assets both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental mortgage | Erstellt am 27. Sept. 2002 Geliefert am 10. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from grainger properties limited (the "borrower") and/or the company and/or any other subsidiary guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (I) f/hold land known as 8 trevor square,london SW7; t/no ngl 641847; (ii) f/hold land known as 24 trevor sq,london SW7; ngl 641845; (iii) f/hold land known as 31 trevor sq,london SW7 1DY; NGL641846; all mortgage,estates or interests in the properties listed and the proceeds of sale thereof with all buildings,trade and other fixtures,plant,machinery,vehicles,computers and other equipment thereon; the benefit of all leases,tenancies and licences and all rental income derived; all credit balances,deposits and cash; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental mortgage | Erstellt am 30. März 2001 Geliefert am 06. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company or any of the borrowers (as defined) and/or any other subsidiary gurarantor (as defined) to the agent and/or any of the lenders (as defined) under or in connection with the finance documents (as defined) or otherwise on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The mortgage dated 13 april 2000 (as defined) shall be read and construed as if the words "any borrower" was substituted for the words "the borrower" in the definition "the secured obligations" in clause 1.1 of the mortgage.. The mortgage shall read as if the following clause was inserted as a new clause numbered 1.2.7 of the mortgage.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 13. Apr. 2000 Geliefert am 27. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the company and/or grainger properties limited to the chargee under the loan agreement dated 31 march 2000, other related documents or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 2 and 7 staveley gardens, londdon W4. AGL45207. F/h property k/a 69 st margarets way twickenham. T/no. MX436235. F/h property k/a 6 and 9 coronation terrace wokingham. T/no. BK252409. And the proceeds of sale thereof and all buildings and trade and other fixtures all plant machinery and other equipment. All rights and interest in the policies of insurance, the benefit of any leases. Floating charge the undertaking and all its property assets and rights present and future. For details of further properties charged please refer to form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 29. Nov. 1994 Geliefert am 12. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1994 Geliefert am 04. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that PR0PERTY k/a 143 church lane rickmansworth. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge with floating charge | Erstellt am 23. Aug. 1994 Geliefert am 24. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 50 alexandra rd richmond. 42 azof street london SE10. 55 brand street west greenwich SE10. And various other properties . floating charge over all undertaking property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat N & D SOUTHERN LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0