BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED

BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02931566
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Seacourt Tower
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BLUE LION CREDIT LIMITED05. Jan. 199505. Jan. 1995
    SINORD 75 LIMITED20. Mai 199420. Mai 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 23. Mai 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 20. Mai 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    18 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 16. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Richard Hill am 13. Juni 2014

    2 SeitenCH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    11 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    16 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Lee als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Wer sind die Geschäftsführer von BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LINNELLS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Seacourt Tower
    United Kingdom
    Sekretär
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Seacourt Tower
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3440292
    56066410006
    HILL, Adrian Richard
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish2107550013
    GEWOLB, Roger Joel
    8 Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    Sekretär
    8 Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    American44119720001
    BLOOMSBURY REGISTRARS LIMITED
    8 Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    Sekretär
    8 Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    55848690001
    SRT CORPORATE SERVICES LIMITED
    Royex House
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7LE London
    Sekretär
    Royex House
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7LE London
    39316210003
    ATKINSON, Sam
    20 Woodhurst South
    Ray Mead Road
    SL6 8NZ Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    20 Woodhurst South
    Ray Mead Road
    SL6 8NZ Maidenhead
    Berkshire
    British62850530003
    DEAN, Kevin John
    18 Haverstock Street
    N1 8DL London
    Geschäftsführer
    18 Haverstock Street
    N1 8DL London
    EnglandBritish38967070001
    GEWOLB, Roger Joel
    8 Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    Geschäftsführer
    8 Coldbath Square
    EC1R 5HL London
    American44119720001
    GISSEL, Peter
    Grove Cottage
    Goose Rye Road, Worplesdon
    GU3 3RJ Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Grove Cottage
    Goose Rye Road, Worplesdon
    GU3 3RJ Guildford
    Surrey
    Danish66093140001
    GULLAN, Alan Graham Hugh
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish51122700007
    GULLAN, Alan Graham Hugh
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish51122700007
    GULLAN, Alan Graham Hugh
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish51122700007
    GULLAN, Alan Graham Hugh
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    55 The Ridgeway
    TN10 4NJ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish51122700007
    JONES, Robert Glyn
    17 Mortons Lane
    RG7 6QQ Upper Bucklebury
    Mulbery House
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    17 Mortons Lane
    RG7 6QQ Upper Bucklebury
    Mulbery House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish116871110003
    JUSTICE, Warren Henry
    35 St Michael's Road
    CF5 2AL Llandaff
    Cardiff
    Geschäftsführer
    35 St Michael's Road
    CF5 2AL Llandaff
    Cardiff
    British110068660001
    LEE, Andrew Philip, Mr.
    110 Bath Road
    SL1 3SZ Slough
    Windsor Gate
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    110 Bath Road
    SL1 3SZ Slough
    Windsor Gate
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish73882180001
    LORIMER, Mark Basil Andrew
    82 Gloucester Street
    SW1V 4EE London
    Geschäftsführer
    82 Gloucester Street
    SW1V 4EE London
    British39512850001
    MANDER, Colin John
    25 Beech Grove
    NP16 5BD Chepstow
    Gwent
    Geschäftsführer
    25 Beech Grove
    NP16 5BD Chepstow
    Gwent
    WalesBritish119561880001
    MILLS, Andrew John
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    British139897970001
    MILLS, Andrew John
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    British139897970001
    MILLS, Andrew John
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    British139897970001
    MILLS, Andrew John
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree Grove
    RG41 4UX Wokingham
    14
    Berkshire
    British139897970001
    POWELL, Tamsin Cerys
    Gurnells Road
    Seer Green
    HP9 2XJ Beaconsfield
    28
    Buckinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Gurnells Road
    Seer Green
    HP9 2XJ Beaconsfield
    28
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish139898270001
    SHEPHERD, Nicola
    St Ives Cottage Bank Street
    Bishops Waltham
    SO32 1AN Hampshire
    Geschäftsführer
    St Ives Cottage Bank Street
    Bishops Waltham
    SO32 1AN Hampshire
    British52905040002
    SINCLAIR, John Barclay
    6 Gillespie House
    Virginia Park
    GU25 4SU Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Gillespie House
    Virginia Park
    GU25 4SU Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish89458370002
    SURTEES, Anthony Conyers
    Potters Hatch House
    Crondall
    GU10 5PW Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Potters Hatch House
    Crondall
    GU10 5PW Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish18075560001
    WOODALL, Michael Alan
    Friars Ford Cottage
    Manor Road, Goring-On-Thames
    RG8 9EP Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Friars Ford Cottage
    Manor Road, Goring-On-Thames
    RG8 9EP Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish43383690001

    Hat BRITISH CREDIT TRUST MANAGEMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 23. Mai 2008
    Geliefert am 30. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, book debts, uncalled capital, fix charge all bank accounts all hp assets and all motor vehicles see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 30. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 20. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any acocunt whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 15. März 2006
    Geliefert am 29. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all book debts; all bank accounts; its uncalled capital; all motor vehicles and by way of floating charge all its undertaking and all its assets, both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 29. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 03. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all book debts and assigns all bank accounts its uncalled capital all hp assets hire purchase agreements and all motor vehicles by way of first floating charge all its right title and interest in the credit insurance policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A fixed and floating security between the borrower and barclays bank PLC in its capacity as security trustee for the benefit of the finance parties
    Erstellt am 15. Nov. 2001
    Geliefert am 04. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future moneys, debts and liabilities due, owing or incurred by the borrower to any finance party under or in connection with any transaction document
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all book debts, bank accounts, uncalled capital, hp assets, hire purchase agreements and all motor vehicles, all its rights and interest under each asset sale agreement, the administration agreement, the bct collections trust, the funding trust and each scottish declaration of trust, all asset documents and asset files, all right title and interest in the credit insurance policy. By way of a first floating charge, all its undertaking and all its assets, both present and future not otherwise assigned or charged above.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 29. Juli 1999
    Geliefert am 11. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party under or in connection with any transaction document
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0