XCESS PROPERTY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameXCESS PROPERTY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02935446
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von XCESS PROPERTY LIMITED?

    • (7012) /

    Wo befindet sich XCESS PROPERTY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BAKER TILLY
    6th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von XCESS PROPERTY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WHOLESALE DIRECT LIMITED03. Juni 199403. Juni 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von XCESS PROPERTY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Juli 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für XCESS PROPERTY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Liquidator's Progress Report 25/07/2011
    13 SeitenLIQ MISC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Old Bailey London Ec4M 7a7 am 29. Nov. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Liquidators

    6 Seiten4.31

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Pricewaterhousecoopers Llp Plumtree Court London EC4A 4HT am 01. Sept. 2010

    2 SeitenAD01

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Beendigung der Bestellung von Paul Sellars als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Umregistrierung

    RES02

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    10 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    15 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    22 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten287

    Vorschlag des Verwalters

    68 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht

    6 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    2 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von XCESS PROPERTY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LAWSON, Timothy David
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    Sekretär
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    British111902410001
    LAWSON, Timothy David
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Brompton House
    School Lane Stadhampton
    OX44 7TR Oxford
    Oxfordshire
    British111902410001
    LITTLE, Mark John James
    Farringford
    Harlestone Road
    NN6 8AU Church Brampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Farringford
    Harlestone Road
    NN6 8AU Church Brampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish149016530001
    KHOSLA, Anil
    71 Osidge Lane
    Southgate
    N14 5JL London
    Sekretär
    71 Osidge Lane
    Southgate
    N14 5JL London
    British39033980001
    LAWSON, Catherine Jane
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    Sekretär
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    British40256810004
    GUFFOGG, Milton Ivan
    14 Clifton House Close
    SG17 5EQ Clifton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    14 Clifton House Close
    SG17 5EQ Clifton
    Bedfordshire
    EnglandBritish185891060001
    LAWSON, Simon James
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Abbey Farm
    Ravensden Road
    MK41 0LA Renhold
    Bedfordshire
    United KingdomUnited Kingdom40209540005
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    THANDI, Satnam Singh
    94 Midland Road
    LU2 0BL Luton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    94 Midland Road
    LU2 0BL Luton
    Bedfordshire
    British39249400001

    Hat XCESS PROPERTY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2003
    Geliefert am 29. Mai 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Marine mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 2002
    Geliefert am 08. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    64/64 shares in the ship 2002 princess 56- GMPPT610H102 heidissa - on 905843 and in its appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Marine mortgage
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 19. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £480,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    2002 princess 56 GBMPPT6107H102.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 19. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 14. Nov. 2001
    Geliefert am 15. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 26 sun street waltham abbey t/no;-EX201493. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Juni 2001
    Geliefert am 03. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 4 & 5 marquis business centre royston road baldock herts. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 26. März 2001
    Geliefert am 29. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a 26 sun street, waltham, abbey, london EN9 1EJ, title number EX201493. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Sept. 2000
    Geliefert am 16. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 1 hitchin street biggleswade bedfordshire title number BD168386. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Sept. 2000
    Geliefert am 16. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 124 shirley high street southampton title number HP566045. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Sept. 2000
    Geliefert am 16. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as unit 8 woodside industrial estate works road letchworth herts. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Juni 1998
    Geliefert am 27. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 8 woodside industrial park works road letchworth herts. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Sept. 1995
    Geliefert am 18. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat XCESS PROPERTY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. Jan. 2007Beginn der Verwaltung
    06. Feb. 2008Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark Nicholas Cropper
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    2
    DatumTyp
    27. Juli 2012Abschluss der Liquidation
    10. Mai 2010Antragsdatum
    23. Juni 2010Beginn der Liquidation
    01. Nov. 2012Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    Praktiker
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    Geoffrey Lambert Carton-Kelly
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praktiker
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0