WELCOME HOLIDAYS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WELCOME HOLIDAYS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02941731 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WELCOME HOLIDAYS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WELCOME HOLIDAYS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sunway House Raglan Road NR32 2LW Lowestoft England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WELCOME HOLIDAYS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROOMCO (799) LIMITED | 22. Juni 1994 | 22. Juni 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WELCOME HOLIDAYS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WELCOME HOLIDAYS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Triangle 4th Floor, 5-17 Hammersmith Grove London W6 0LG England zum Sunway House Raglan Road Lowestoft NR32 2LW am 25. Aug. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Garry Clark Adam am 08. Dez. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Triangle 5-17 Hammersmith Grove London W6 0LG zum The Triangle 4th Floor, 5-17 Hammersmith Grove London W6 0LG am 20. Jan. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung von Mr Henrik Vilhelm Kjellberg als Direktor am 20. Nov. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of Hoseasons Holidays Limited as a person with significant control on 04. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Vacation Rental Group Holdings Limited as a person with significant control on 04. Jan. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Change of details for Vacation Rental Group Holdings Limited as a person with significant control on 08. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Hoseasons Holidays Limited als Geschäftsführer am 16. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Garry Adam als Direktor am 07. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WELCOME HOLIDAYS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM, Garry Clark | Geschäftsführer | Raglan Road NR32 2LW Lowestoft Sunway House England | England | British | 150460730002 | |||||||||
| KELLY, Lynn Catherine | Geschäftsführer | Raglan Road NR32 2LW Lowestoft Sunway House England | England | British | 157433920001 | |||||||||
| KJELLBERG, Henrik Vilhelm | Geschäftsführer | Raglan Road NR32 2LW Lowestoft Sunway House England | United Kingdom | Swedish | 244090880001 | |||||||||
| BAILEY, Michael John | Sekretär | Low Field Farm Threshfield BD23 5PN Skipton North Yorkshire | British | 40485230004 | ||||||||||
| BAILEY, Victoria Louise | Sekretär | Granville House Bellbusk Gargrave BD23 4DV Skipton North Yorkshire | British | 40485050001 | ||||||||||
| BANKES, Henry Francis John | Sekretär | Cadeleigh Court Cadeleigh EX16 8RY Tiverton Devon | British | 102155820002 | ||||||||||
| BANKES, Henry Francis John | Sekretär | 67 Blenheim Terrace NW8 0EJ London | British | 102155820001 | ||||||||||
| NASTA, Marius Ion | Sekretär | 44 Wynnstay Gardens Allen Street W8 6UT London | Belgian | 50087790005 | ||||||||||
| NASTA, Marius Ion | Sekretär | 44 Wynnstay Gardens Allen Street W8 6UT London | Belgian | 50087790005 | ||||||||||
| PEACE, Michael James | Sekretär | 24 Haverholt Road BB8 9PT Colne Lancashire | British | 54091830001 | ||||||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||||||
| AILLES, Ian Simon | Geschäftsführer | Beaumont Avenue AL1 4TP St. Albans 84 Hertfordshire | England | British | 128695490001 | |||||||||
| BAILEY, Michael John | Geschäftsführer | Low Field Farm Threshfield BD23 5PN Skipton North Yorkshire | British | 40485230004 | ||||||||||
| BRENNAN, William Joseph | Geschäftsführer | 28 Priory Road Kew TW9 3DH London | United States | 97989400002 | ||||||||||
| DEUTSCH, Franz Markus | Geschäftsführer | 4 Wildflower Trail Greenwich Ct06831 Usa | United States | Austrian | 179570660001 | |||||||||
| FORBES, Scott Edward | Geschäftsführer | Flat 1 44 Cranley Gardens SW7 3DE London | England | British | 106973270001 | |||||||||
| GIAMALVA, Frank Peter | Geschäftsführer | 46 Cheval Place SW7 1ER London | American | 104404420003 | ||||||||||
| HUGHES, Andrew Lawrence | Geschäftsführer | 7 Brooke Close LE15 6GD Oakham Leicestershire | England | British | 109749210001 | |||||||||
| LIGGINS, Andrew | Geschäftsführer | 4 Mulberry Court Drayton, Market Harborough LE16 8RG Leicestershire | England | British | 124162050002 | |||||||||
| MAGOOLAGAN, Nicholas Paul | Geschäftsführer | Thorncliffe Hetton BD23 6LT Skipton North Yorkshire | British | 8418420001 | ||||||||||
| NASTA, Marius Ion | Geschäftsführer | 44 Wynnstay Gardens Allen Street W8 6UT London | Belgian | 50087790005 | ||||||||||
| NICHOLS, John Paul | Geschäftsführer | 37 Stanhope Gardens South Kensington SW7 5QY London Flat 1 United Kingdom | British | 118231270002 | ||||||||||
| ROGERSON, Ian Fraser | Geschäftsführer | Oxford Street SN8 2DQ Aldbourne 27 Wiltshire United Kingdom | England | British | 122973770001 | |||||||||
| THOMAS, Duleep | Geschäftsführer | Monastery Close Abbey Mill Lane AL3 4HA St Albans 4 United Kingdom | United States | 137345340001 | ||||||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||||||
| HOSEASONS HOLIDAYS LIMITED | Geschäftsführer | Earby BB94 0AA Barnoldswick Spring Mill Lancashire |
| 150290990004 | ||||||||||
| RCI EUROPE | Geschäftsführer | NN15 6EY Kettering Kettering Parkway Northants United Kingdom | 137040480001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WELCOME HOLIDAYS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoseasons Holidays Limited | 04. Jan. 2018 | Earby BB94 0AA Barnoldswick Spring Mill England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Vacation Rental Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 5-17 Hammersmith Grove W6 0LG London The Triangle England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WELCOME HOLIDAYS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 02. Juni 2000 Geliefert am 08. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it. Right, title and interest present and future in the policy.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 08. Okt. 1999 Geliefert am 22. Okt. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it. Right, title and interest present and future in the policy.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Okt. 1999 Geliefert am 22. Okt. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 1998 Geliefert am 16. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Sept. 1994 Geliefert am 28. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0