ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED

ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02941825
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED?

    • Vermietung und Leasing von Passagierlufttransportgeräten (77351) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5th Floor 6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MONARCH GLASS PROTECTION SERVICES LIMITED01. Juli 199401. Juli 1994
    GIFTBAND LIMITED23. Juni 199423. Juni 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Margaret Creevey als Geschäftsführer am 02. Apr. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Brendan O'neill als Direktor am 02. Apr. 2018

    2 SeitenAP01

    Notification of Investment Corporation of Dubai as a person with significant control on 17. Aug. 2017

    2 SeitenPSC03

    Cessation of Guy Hands as a person with significant control on 17. Aug. 2017

    1 SeitenPSC07

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2017 bis 31. Dez. 2017

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2016

    18 SeitenAA

    Ernennung von Tmf Corporate Administration Services Limited als Sekretär am 03. Aug. 2017

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Joint Secretarial Services Limited als Sekretär am 03. Aug. 2017

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Stephen William Spencer Norton als Direktor am 01. Jan. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Roy Neil Arthur als Geschäftsführer am 31. Dez. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Jennifer Margaret Creevey als Direktor am 28. Sept. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Simon Jeremy Glass als Geschäftsführer am 28. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2015

    18 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Simon Jeremy Glass am 23. Mai 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 20. Juni 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Beschlüsse

    Resolutions
    44 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beendigung der Bestellung von Vincent Cheshire als Geschäftsführer am 09. Okt. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Vincent Cheshire als Direktor am 06. Okt. 2015

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Simon Jeremy Glass am 15. Jan. 2015

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer06902863
    140723560001
    ELGAR, Mark Jonathan
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158165140003
    NORTON, Stephen William Spencer
    5th Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    C/O Tmf Corporate Administration Services Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    5th Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    C/O Tmf Corporate Administration Services Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish221919870001
    O'NEILL, Brendan
    5th Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    C/O Tmf Corporate Administration Services Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    5th Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    C/O Tmf Corporate Administration Services Limited
    United Kingdom
    IrelandIrish245367870001
    FREAKLEY, Simon Vincent
    34 Fitzjames Avenue
    W14 0RR London
    Sekretär
    34 Fitzjames Avenue
    W14 0RR London
    British96967960001
    GLEDHILL, Mary Elizabeth
    Crown Cottage 11 Crown Hill
    Ropsley
    NG33 4BH Grantham
    Lincolnshire
    Sekretär
    Crown Cottage 11 Crown Hill
    Ropsley
    NG33 4BH Grantham
    Lincolnshire
    British60726470001
    MAUNDER, Crispin
    13 Gloucester Walk
    Kensington
    W8 4HZ London
    Sekretär
    13 Gloucester Walk
    Kensington
    W8 4HZ London
    British43548740001
    JOINT SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    England
    Sekretär
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    England
    83551780003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WFW LEGAL SERVICES LIMITED
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    Sekretär
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    18093320001
    ARTHUR, Roy Neil
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    United KingdomBritish66175050001
    BASRAN, Tarsem
    33 Walnut Tree House
    Tregunter Road Chelsea
    SW10 9HJ London
    Geschäftsführer
    33 Walnut Tree House
    Tregunter Road Chelsea
    SW10 9HJ London
    British108546970001
    BLOEMEN, John Frederick Louis
    First Floor
    36 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    Geschäftsführer
    First Floor
    36 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    Us Citizen114254400001
    CHESHIRE, Vincent
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    Geschäftsführer
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United KingdomBritish85252810001
    COHEN, Andre Maurice
    Long Marling Down Lane
    Frant
    TN3 9HP Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Long Marling Down Lane
    Frant
    TN3 9HP Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandAustralian43548660001
    CREEVEY, Jennifer Margaret
    5th Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    C/O Tmf Corporate Administration Services Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    5th Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    C/O Tmf Corporate Administration Services Limited
    United Kingdom
    IrelandIrish158165130004
    CREEVEY, Jennifer Margaret
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    IrelandIrish158165130004
    FRANK, Alexander Charles
    1192 Park Avenue
    Apartment 2c
    New York
    Ny 10128
    United States Of America
    Geschäftsführer
    1192 Park Avenue
    Apartment 2c
    New York
    Ny 10128
    United States Of America
    American72981480001
    FREAKLEY, Simon Vincent
    34 Fitzjames Avenue
    W14 0RR London
    Geschäftsführer
    34 Fitzjames Avenue
    W14 0RR London
    United KingdomBritish96967960001
    GLASS, Simon Jeremy
    Block B, Riverside Iv
    Sir John Rogerson's Quay
    Dublin 2
    C/O Awas (Ireland) Limited
    Ireland
    Geschäftsführer
    Block B, Riverside Iv
    Sir John Rogerson's Quay
    Dublin 2
    C/O Awas (Ireland) Limited
    Ireland
    IrelandBritish172144770038
    GRAHAM, Charles Stuart
    Rembrandtweg 178 C
    Amsterdam 1181 G2
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Rembrandtweg 178 C
    Amsterdam 1181 G2
    Netherlands
    British58490130001
    GRAY, James Young
    The Sweepstakes
    Ballsbridge
    Dublin 4
    105
    Ireland
    Geschäftsführer
    The Sweepstakes
    Ballsbridge
    Dublin 4
    105
    Ireland
    IrelandBritish132692880001
    HUSAIN, Tariq Charles Anthony
    Battersea Park Road
    Wandsworth
    SW11 4LR London
    473
    Geschäftsführer
    Battersea Park Road
    Wandsworth
    SW11 4LR London
    473
    United KingdomBritish35204420006
    JACKSON, Alan Peter
    Laurel Farm
    SN16 9LH Malmesbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Laurel Farm
    SN16 9LH Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomEnglish79865470001
    MANNING, Lee Anthony
    84 Grosvenor Street
    W1X 9DF London
    Geschäftsführer
    84 Grosvenor Street
    W1X 9DF London
    British53211360001
    MASON, Maurice
    Wellfield House
    Ballymore Eustace
    County Kildare
    Ireland
    Geschäftsführer
    Wellfield House
    Ballymore Eustace
    County Kildare
    Ireland
    Irish72336080001
    MAUNDER, Crispin
    13 Gloucester Walk
    Kensington
    W8 4HZ London
    Geschäftsführer
    13 Gloucester Walk
    Kensington
    W8 4HZ London
    British43548740001
    MURCHISON, Hamish Charles
    Apartment 22 Bloomfield Park
    Bloomfield Avenue
    IRISH Donnybrook
    Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Apartment 22 Bloomfield Park
    Bloomfield Avenue
    IRISH Donnybrook
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandBritish125955600001
    O'SULLIVAN, Jean
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    IrelandIrish158595000001
    PETERSON, Carl Scott
    15 Redington Road
    NW3 7QX London
    Geschäftsführer
    15 Redington Road
    NW3 7QX London
    American71786810001
    RICHARDS, Jason Anthony
    Alexandra Court
    Alexandra Road
    SL4 1HH Windsor
    1
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Alexandra Court
    Alexandra Road
    SL4 1HH Windsor
    1
    Berkshire
    United KingdomBritish149207210001
    STEHRENBERGER, Peter Walter
    The Knapp
    Oak Way
    RH2 7ES Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Knapp
    Oak Way
    RH2 7ES Reigate
    Surrey
    Swiss415350001
    STEWART, Alan James
    Culmington Road
    Ealing
    W13 9NJ London
    19
    Geschäftsführer
    Culmington Road
    Ealing
    W13 9NJ London
    19
    United KingdomBritish149206970001
    WARD, Barbara Kay
    57 York Road
    Queens Park
    New South Wales 2022
    Australia
    Geschäftsführer
    57 York Road
    Queens Park
    New South Wales 2022
    Australia
    Australian47262100001
    WATKINSON, Jonathan Richard William
    Flat 23 Lionel Mansions
    Haarlem Road
    W14 0JH London
    Geschäftsführer
    Flat 23 Lionel Mansions
    Haarlem Road
    W14 0JH London
    British101294880001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Investment Corporation Of Dubai
    Gate Village, P.O.Box 333888
    Dubai
    Building 7, Level 6
    United Arab Emirates
    17. Aug. 2017
    Gate Village, P.O.Box 333888
    Dubai
    Building 7, Level 6
    United Arab Emirates
    Nein
    RechtsformGovernment Department
    RechtsgrundlageCorporation (Incorporated By Royal Decree)
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Mr Guy Hands
    Royal Chambers
    St Julians Avenue
    GY1 3RE St Peter Port
    4th Floor
    Guernsey
    06. Apr. 2016
    Royal Chambers
    St Julians Avenue
    GY1 3RE St Peter Port
    4th Floor
    Guernsey
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Guernsey
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat ANSETT WORLDWIDE AVIATION UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Aircraft mortgage and security agreement
    Erstellt am 18. Okt. 2010
    Geliefert am 02. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the trustee or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to all leases with respect to the pool aircraft, all rights to receive moneys due, proceeds of any insurance, warranty and claims for damages pursuant to such assigned leases, all security assignments, the pledged beneficial interest, the pledged stock, the pledged membership interests, all other investment property, each securities account. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank Northwest, National Association
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee, to the first priority representative or to any first priority secured party and to the second priority representative or to any second priority secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being the lease agreement dated 21 march 2003 and all other rights and benefits whatsoever accruing to the assignor under the lease documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Trust Company Americas (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee, to the first priority representative or to any first priority secured party and to the second priority representative or to any second priority secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being the lease agreement dated 14 november 2003 and all other rights and benefits whatsoever accruing to the assignor under the lease documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Trust Company Americas (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee, to the first priority representative or to any first priority secured party and to the second priority representative or to any second priority secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being the lease agreement dated 14 november 2003 and all other rights and benefits whatsoever accruing to the assignor under the lease documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Trust Company Americas (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee, to the first priority representative or to any first priority secured party and to the second priority representative or to any second priority secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being the lease agreement dated 31 october 2003 and all other rights and benefits whatsoever accruing to the assignor under the lease documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Trust Company Americas (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security assignment
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee, to the first priority representative or to any first priority secured party and to the second priority representative or to any second priority secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being the lease agreement dated as of 26 march 2004 and all other rights and benefits whatsoever accruing to the assignor under the lease documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Trust Company Americas (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 24. März 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee, to the first priority representative or to any first priority secured party and to the second priority representative or to any second priority secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first priority security interest in the contracts, each lease, the accounts, the beneficial interests in each owner trust, the intercompany notes and any other permitted intercompany indebtedness. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Trust Company Americas (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Sept. 2001
    Geliefert am 20. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The tenants obligations as defined in the deposit deed to the chargee
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest (as tenant) in and to the account the deposit balance and all money withdrawn from said account.
    Berechtigte Personen
    • Bbc Pension Trust Limited
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of deposit
    Erstellt am 09. Feb. 2001
    Geliefert am 15. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 3 october 1985
    Kurze Angaben
    The sum of £51,950.
    Berechtigte Personen
    • Bbc Pension Trust Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Account charge no.3
    Erstellt am 04. Aug. 1995
    Geliefert am 24. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this account charge no.3 (And any and all such moneys, liabilities and obligations of the chargor shall form part of the outstanding obligations whether or not the chargor is personally liable for the same and whether or not any recourse may be had with respect thereto against the chargor and/or its assets and (without limiting the foregoing) notwithstanding the provisions of clauses 8.2 and 8.3 of sub-lease no.3 Or any other similar provision contained in any other operative document, and the agreement and the security interest created by this charge shall secure and be enforceable in respect of the same)
    Kurze Angaben
    The chargor charges by way of first fixed charge to the chargee all of its right, title and interst in and to the collateral as security for the full and punctual payment, performance and discharge of all the outstanding obligations.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kassarine Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Account charge no. 2
    Erstellt am 04. Aug. 1995
    Geliefert am 24. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this account charge no.2 (And any and all such moneys, liabilities and obligations of the chargor shall form part of the outstanding obligations whether or not the chargor is personally liable for the same and whether or not any recourse may be had with respect thereto against the chargor and/or its assets and (without limiting the foregoing) notwithstanding the provisions of clauses 8.2 and 8.3 of sub-lease no.2 Or any other similar provision contained in any other operative document, and this charge and security interest created by this charge shall secure and be enforceable in respect of the same)
    Kurze Angaben
    The chargor charges by way of first fixed charge to the chargee all of its right, title and interest in and to the collateral as security for the full and punctual payment, performance and discharge of all the outstanding obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kassarine Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Account charge no.1
    Erstellt am 04. Aug. 1995
    Geliefert am 24. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this account charge no.1 (And any and all such moneys, liabilities and obligations of the chargor shall form part of the outstanding obligations whether or not the chargor is personally liable for the same and whether or not any recourse may be had with respect thereto against the chargor and/or its assets and (without limiting the foregoing) notwithstanding the provisions of clauses 8.2 and 8.3 of sub-lease no.1 Or any other similar provision contained in any other operative document, and this charge and the security interest created by this charge shall secure and be enforceable in respect of the same)
    Kurze Angaben
    The chargor charges by way of first fixed charge to the chargee all of its right, title and interest in and to the collateral as security for the full and punctual performance and discharge of all the outstanding obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kassarine Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-lease assignment no. 3
    Erstellt am 04. Aug. 1995
    Geliefert am 24. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this sub-lease assignment no. 3 (and any and all such moneys, liabilities and obligations of the assignor shall form part of the outstanding obligations whether or not the assignor is personally liable for the same and whether or not any recourse may be had with respect thereto against the assignor and/or its assets and (without limiting the foregoing) notwithstanding the provisions of clauses 8.2 and 8.3 of sub-lease no.3 Or any other similar provision contained in any other operative document and this agreement and the security interest created by this agreement shall secure and be enforceable in respect of the same)
    Kurze Angaben
    The assignor assigned and agreed to assign by way of security the assigned property to and in favour of the assignee. Assigned property means collectively, all of the right, title and interest, present and future:. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kassarine Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-lease assignment no. 2
    Erstellt am 04. Aug. 1995
    Geliefert am 24. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this sub-lease assignment no. 2 (and any and all such moneys, liabilities and obligations of the assignor shall form part of the outstanding obligations whether or not the assignor is personally liable for the same and whether or not any recourse may be had with respect thereto against the assignor and/or its assets and (without limiting the foregoing) not withstanding the provisions of clauses 8.2 and 8.3 of sub-lease no.2 Or any other similar provision contained in any other operative document and this agreement and the secuity interest created by this agreement shall secure and be enforceable in respect of the same)
    Kurze Angaben
    The assignor assigned and agreed to assign by way of security the assigned property to and in favour of the assignee. Assigned property means collectively, all of the right, title and interest, present and future:. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kassarine Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Sub-lease assignment no. 1
    Erstellt am 04. Aug. 1995
    Geliefert am 24. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this sub-lease assignment no. 1 (and any and all such moneys, liabilities and obligations of the assignor shall form part of the outstanding obligations whether or not the assignor is personally liable for the same and whether or not any recourse may be had with respect thereto against the assignor and/or its assets and (without limiting the foregoing) notwithstanding the provisions of clauses 8.2 and 8.3 of sub-lease no.1 Or any other similar provision contained in any other operative document and this agreement and the security interest created by this agreement shall secure and be enforceable in respect of the same)
    Kurze Angaben
    The assignor assigned and agreed to assign by way of security the assigned property to and in favour of the assignee. Assigned property means collectively, all the right, title and interest, present and future:. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kassarine Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0