LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02953302 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED?
- Vermietung und Leasing von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (77110) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LOMBARD CONTRACT HIRE (2) LIMITED | 12. Dez. 1994 | 12. Dez. 1994 |
| PEARLEDGE LIMITED | 27. Juli 1994 | 27. Juli 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Verschiedenes Ad 03 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 01. Juni 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Gittins als Sekretär am 28. Juni 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Dermot Hennessey als Sekretär am 28. Juni 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Laura Jane Briely als Geschäftsführer am 30. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Laura Jane Briely am 25. Jan. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Sarah Marie Coles als Direktor am 01. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rachael Mary Biles als Geschäftsführer am 19. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carol Ann Parkes als Geschäftsführer am 19. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Laura Jane Briely als Direktor am 19. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENNESSEY, David Dermot | Sekretär | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | 210084650001 | |||||||
| COLES, Sarah Marie | Geschäftsführer | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 199049910001 | |||||
| COLES, Pamela Mary | Sekretär | 41 Baring Road HP9 2NB Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980001 | ||||||
| GITTINS, Paul | Sekretär | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | British | 45660860003 | ||||||
| IVES, Deborah Ann | Sekretär | Chukwani The Friary Old Windsor SL4 2NS Windsor Berkshire | British | 61720060001 | ||||||
| RICHARDSON, Elaine | Sekretär | The Willows Willowside London Colney AL2 1DP St Albans Hertfordshire | British | 36633090001 | ||||||
| YOUNG, Mark Lees | Sekretär | 68 Wycherley Crescent EN5 1AP New Barnet Hertfordshire | British | 32782910002 | ||||||
| YOUNG, Mark Lees | Sekretär | 68 Wycherley Crescent EN5 1AP New Barnet Hertfordshire | British | 32782910002 | ||||||
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 1278390004 | |||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| BALLINGALL, Stuart James | Geschäftsführer | 39 Craigleith Drive EH4 3JU Edinburgh Midlothian | British | 118506820001 | ||||||
| BILES, Rachael Mary | Geschäftsführer | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 193660400001 | |||||
| BRIELY, Laura Jane | Geschäftsführer | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 193660390001 | |||||
| CARTWRIGHT, John David | Geschäftsführer | 12 Temple Street HP18 9SX Brill Buckinghamshire | British | 78040540001 | ||||||
| CHESSMAN, Mark Francis | Geschäftsführer | Hatchford Way B26 3RZ Birmingham Blake House United Kingdom | England | British | 196385070001 | |||||
| COLES, Pamela Mary | Geschäftsführer | 41 Baring Road HP9 2NB Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980001 | ||||||
| CORMICK, Charles Bruce Arthur | Geschäftsführer | Flat 2 11 Pembridge Crescent W11 3DT London | United Kingdom | British | 17946190001 | |||||
| EASTER, Philip Charles | Geschäftsführer | Arlington House Arlington Lane NR2 2DB Norwich | England | British | 105999210001 | |||||
| FEWSTER, Roy Robson | Geschäftsführer | Woodend Rosedale Abbey YO18 8SE Pickering North Yorkshire | British | 50065350001 | ||||||
| FOULDS, David Michael | Geschäftsführer | 8 Upper Hollis HP16 9HP Great Missenden Buckinghamshire | England | British | 122016350001 | |||||
| FRANCIS, Rick | Geschäftsführer | Hatchford Way B26 3RZ Birmingham Blake House United Kingdom | England | British | 180380320001 | |||||
| FRANCIS, Rick | Geschäftsführer | Ravenswood House Coventry Road CV47 1BG Southam Warwickshire | England | British | 180380320001 | |||||
| GALLOWAY, David Allistair | Geschäftsführer | Gyldernscroft 1 Henley Road SL7 2BZ Marlow Buckinghamshire | British | 305790001 | ||||||
| HARRIS, Peter Robert | Geschäftsführer | Four Winds Fireball Hill SL5 9PJ Sunningdale Berkshire | United Kingdom | British | 50619920001 | |||||
| HARRIS, Peter Robert | Geschäftsführer | Four Winds Fireball Hill SL5 9PJ Sunningdale Berkshire | United Kingdom | British | 50619920001 | |||||
| HAY, Andrew John | Geschäftsführer | Highcroft Northfield Place KT13 0RF Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 124994940001 | |||||
| IVES, Deborah Ann | Geschäftsführer | Chukwani The Friary Old Windsor SL4 2NS Windsor Berkshire | British | 61720060001 | ||||||
| MACHELL, Simon Christopher | Geschäftsführer | Gooch's Farm Rushall IP21 4QB Diss Norfolk | British | 145338560001 | ||||||
| PARKES, Carol Ann | Geschäftsführer | Heathside Park Road SK3 0RB Stockport Heathside Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139996590027 | |||||
| ROBERTS, Paul Christopher | Geschäftsführer | 34 Ashchurch Grove W12 9BU London | British | 59926960002 | ||||||
| SNOWBALL, Patrick Joseph Robert | Geschäftsführer | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | British | 38351740003 | ||||||
| STEAD, Nigel Cleator | Geschäftsführer | Blake House Hatchford Way B26 3RZ Birmingham Lex Autolease England England | England | British | 47582470001 | |||||
| TOWN, Lindsay John | Geschäftsführer | 10 Ferndale TN2 3PB Tunbridge Wells Kent | England | British | 64287260001 | |||||
| WALDEN, Jonathan Kim | Geschäftsführer | Hyatt Lodge Long Walk HP8 4AW Chalfont St Giles Buckinghamshire England | England | British | 3809630002 | |||||
| WASSALL, Jonathan Wayne | Geschäftsführer | Theatre Street CV34 4DP Warwick 29 Warwickshire | England | British | 111940630001 |
Hat LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A fixed and floating security document | Erstellt am 26. Okt. 2005 Geliefert am 03. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging group companies to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 16. Juli 2004 Geliefert am 27. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the other initial charging companies to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A fixed and floating security document (the "debenture") | Erstellt am 07. Dez. 2001 Geliefert am 14. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,liabilities and obligations due or to become due from the charging group companies (as defined) to the chargee (the "hedging bank") under or pursuant to the swap documents (as defined) or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between the company and halifax PLC as agent and trustee for the finance parties (the security trustee) | Erstellt am 31. Dez. 1998 Geliefert am 06. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys liabilities and obligations due or to become due by the charging group companies (as defined) to the finance parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 1998 Geliefert am 09. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LEX VEHICLE PARTNERS (2) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0