GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED

GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02955426
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROSSCO (NO.115) LIMITED03. Aug. 199403. Aug. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Mark Fletcher Jopling als Geschäftsführer am 28. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Peter On als Geschäftsführer am 28. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Quentin Patrick Couch als Geschäftsführer am 28. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Peter On am 17. Mai 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    12 SeitenAA

    Ernennung von Mark Greenwood als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Nicholas Mark Fletcher Jopling als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Peter Quentin Patrick Couch als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 12. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Nick On am 16. Sept. 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Rupert Dickinson als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    13 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Sekretär
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    EnglandBritish74581390003
    GREENWOOD, Mark
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    United KingdomBritish154194730002
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Sekretär
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Sekretär
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Geschäftsführer
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Geschäftsführer
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish8256950001
    FIELDER, James
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    Geschäftsführer
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    United KingdomBritish72574940002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    Geschäftsführer
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    EnglandBritish60099210003
    ON, Nicholas Peter
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish135860930002
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001

    Hat GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 23. Okt. 2001
    Geliefert am 08. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The total principle sum of £1,575,000 together with all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings at 179 high street lincoln t/no: LL27733.
    Berechtigte Personen
    • Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 22. Juni 2001
    Geliefert am 28. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £12,501,016 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the principal deeds (including for the avoidance of doubt the termination payment) and this charge
    Kurze Angaben
    By way of assignment to the lender the benefit f the deposit and subject to the reassignment of the deposit (or such of it is still subsisting and vested in the lender) on repayment to the lender of the loan in full.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Annuities Limited
    Transaktionen
    • 28. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed of charge
    Erstellt am 30. Sept. 1999
    Geliefert am 06. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal sum of £5,607,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge dated 3RD april 1987 and further advances (the "loan") and £1,300,000 due or to become due from the company to the chargee (the "further advance")
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 1-4 jubilee way winsford cheshire t/no: CH380718.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Annuities Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 26. Mai 1998
    Geliefert am 28. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal sum of £5,607,000 together with any further advances made by the chargee pursuant to the provisions of the 1987 deed (as defined)
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as queens parade,fountain court and dingle walk,winsford,cheshire; t/nos:CH287801,CH356569,CH384588 and CH402094; the benefit of all rights and/or buildings and all insurances thereto; see form 395 for full details. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Annuities Limited
    Transaktionen
    • 28. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 17. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. due or to become due from the company to the chargee and all other monies intended to be secured by the above deed and existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 55 station road clacton.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 19. Dez. 1997
    Geliefert am 05. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 24TH february 1984, 23 december 1985, 26TH june 1986, 27TH november 1987, 27TH november 1987, 31ST march 1989, 30TH june 1994, 31ST march 1995, 29TH september 1995 and 13TH june 1997 to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage f/h property on the south east side of hinckley road coventry t/n-WK352152 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 13. Juni 1997
    Geliefert am 17. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust PLC and all other monies intended to be secured by the deed of release and substitution and the deeds dated 24/2/84, 23/12/85, 26/6/86, 27/11/87, 27/11/87 ,31/3/89, 30/6/94, 31/3/95 and 29/9/95 to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    The f/h properties k/a 179 high street lincoln and lancaster house 36 orchard street lincoln together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 10. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h land comprising the shopping centre winsford cheshire t/n's CH287801, CH38458 and CH356569 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon and assigns the goodwill of the business.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 30. Sept. 1996
    Geliefert am 10. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of the benefit of all rents, licence or tenancy fees payable by any lessee, licence or tenant of any part of the shopping centre winsford cheshire (as defined in the mortgage deed of even date).
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    Erstellt am 29. Sept. 1995
    Geliefert am 04. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Kurze Angaben
    Freehold property known as land and buildings lying to the east of derby road,huyton,merseyside title number MS291314 and a floating charge over all property assets including any uncalled capital and all monies payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Guaradian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 1997Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 24. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 29. Nov. 1994
    Geliefert am 12. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Acquisition of property
    Erstellt am 12. Nov. 1994
    Erworben am 25. Okt. 1994
    Geliefert am 12. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £7,850,000
    Kurze Angaben
    Lancaster house 36 orchard street lincoln t/no LL46183.
    Berechtigte Personen
    • Friends Provident Life Office
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1994Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 20. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Acquisition of property
    Erstellt am 12. Nov. 1994
    Erworben am 25. Okt. 1994
    Geliefert am 12. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £7,850,000
    Kurze Angaben
    Winsford town centre cheshire t/no CH287801.
    Berechtigte Personen
    • Friends Provident Life Office
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1994Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 19. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    "C" loan notes charge
    Erstellt am 08. Nov. 1994
    Erworben am 25. Okt. 1994
    Geliefert am 08. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due
    Kurze Angaben
    179 high street lincoln t/no LL27733. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1994Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 20. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    "C" loan notes charge
    Erstellt am 08. Nov. 1994
    Erworben am 25. Okt. 1994
    Geliefert am 08. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due
    Kurze Angaben
    F/H property k/a lancaster house lincoln t/no LL46183 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1994Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 20. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Sept. 1988
    Erworben am 14. Juni 1995
    Geliefert am 04. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £6,850,000.00
    Kurze Angaben
    Land and buildings at queens parade fountain court and dingle walk winsford cheshire t/n-CH287801, CH384588 and CH356569.
    Berechtigte Personen
    • Freinds Provident Life Office
    Transaktionen
    • 04. Juli 1995Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 19. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0