GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02955426 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
- (7011) /
- (7020) /
Wo befindet sich GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Citygate Saint James Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CROSSCO (NO.115) LIMITED | 03. Aug. 1994 | 03. Aug. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Mark Fletcher Jopling als Geschäftsführer am 28. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Peter On als Geschäftsführer am 28. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Quentin Patrick Couch als Geschäftsführer am 28. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Peter On am 17. Mai 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mark Greenwood als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Nicholas Mark Fletcher Jopling als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Peter Quentin Patrick Couch als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nick On am 16. Sept. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rupert Dickinson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDLE, Michael Patrick | Sekretär | Stanton Townhead NE65 8PR Morpeth High Priar Northumberland | British | 135308530001 | ||||||
| CUNNINGHAM, Andrew Rolland | Geschäftsführer | Montagu Avenue NE3 4JH Newcastle Upon Tyne 35 Tyne And Wear | England | British | 74581390003 | |||||
| GREENWOOD, Mark | Geschäftsführer | Slayley NE47 0AA Hexham Winter House Northumberland | United Kingdom | British | 154194730002 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Sekretär | 9 The Copse Burnopfield NE16 6HA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 65421150001 | ||||||
| GLANVILLE, Marie Louise | Sekretär | 28 Bramhall Drive High Generals Wood Rickleton NE38 9DB Washington Tyne & Wear | English | 86483290001 | ||||||
| MILBURN, Peter Michael | Sekretär | Derwent Lodge DH8 0TG Shotley Bridge County Durham | British | 36406380001 | ||||||
| DICKINSON DEES | Bevollmächtigter Sekretär | St Anns Wharf 112 Quayside NE99 1SB Newcastle Upon Tyne | 900005460001 | |||||||
| CARE, Timothy James | Bevollmächtigter Geschäftsführer | West House Whorlton Hall Farm Westerhope NE5 1NP Newcastle Upon Tyne | British | 900005450001 | ||||||
| COUCH, Peter Quentin Patrick | Geschäftsführer | Amberley GL5 5AG Gloucestershire Follifoot House | Uk | British | 156117090001 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Geschäftsführer | 17 Lintzford Road Hamsterley Mill Rowlands Gill NE39 1HA Newcastle Upon Tyne | England | British | 65421150003 | |||||
| DICKINSON, Rupert Jerome | Geschäftsführer | 59 Albert Bridge Road SW11 4AQ London | United Kingdom | British | 60267600001 | |||||
| DICKINSON, Stephen | Geschäftsführer | Crow Hall NE47 7BJ Bardon Mill Northumberland | United Kingdom | British | 8256950001 | |||||
| FIELDER, James | Geschäftsführer | 10 Bishops Road SW8 7AB London | United Kingdom | British | 72574940002 | |||||
| JOPLING, Nicholas Mark Fletcher | Geschäftsführer | Chipstead Street SW6 3SS London 28 | England | British | 60099210003 | |||||
| ON, Nicholas Peter | Geschäftsführer | The Links NE26 1RS Whitley Bay 31 Tyne And Wear | United Kingdom | British | 135860930002 | |||||
| SLADE, Sean Anthony | Geschäftsführer | Idlewood Maidenhead Road SL6 9DF Cookham Berkshire | British | 94640230001 |
Hat GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 2001 Geliefert am 08. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The total principle sum of £1,575,000 together with all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings at 179 high street lincoln t/no: LL27733. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 22. Juni 2001 Geliefert am 28. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £12,501,016 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the principal deeds (including for the avoidance of doubt the termination payment) and this charge | |
Kurze Angaben By way of assignment to the lender the benefit f the deposit and subject to the reassignment of the deposit (or such of it is still subsisting and vested in the lender) on repayment to the lender of the loan in full. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of charge | Erstellt am 30. Sept. 1999 Geliefert am 06. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal sum of £5,607,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge dated 3RD april 1987 and further advances (the "loan") and £1,300,000 due or to become due from the company to the chargee (the "further advance") | |
Kurze Angaben L/H property k/a 1-4 jubilee way winsford cheshire t/no: CH380718. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 26. Mai 1998 Geliefert am 28. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal sum of £5,607,000 together with any further advances made by the chargee pursuant to the provisions of the 1987 deed (as defined) | |
Kurze Angaben L/Hold property known as queens parade,fountain court and dingle walk,winsford,cheshire; t/nos:CH287801,CH356569,CH384588 and CH402094; the benefit of all rights and/or buildings and all insurances thereto; see form 395 for full details. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 30. Jan. 1998 Geliefert am 17. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. due or to become due from the company to the chargee and all other monies intended to be secured by the above deed and existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben F/H property k/a 55 station road clacton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 19. Dez. 1997 Geliefert am 05. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee the principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 24TH february 1984, 23 december 1985, 26TH june 1986, 27TH november 1987, 27TH november 1987, 31ST march 1989, 30TH june 1994, 31ST march 1995, 29TH september 1995 and 13TH june 1997 to which it is supplemental | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage f/h property on the south east side of hinckley road coventry t/n-WK352152 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 13. Juni 1997 Geliefert am 17. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust PLC and all other monies intended to be secured by the deed of release and substitution and the deeds dated 24/2/84, 23/12/85, 26/6/86, 27/11/87, 27/11/87 ,31/3/89, 30/6/94, 31/3/95 and 29/9/95 to which it is supplemental | |
Kurze Angaben The f/h properties k/a 179 high street lincoln and lancaster house 36 orchard street lincoln together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1996 Geliefert am 10. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the l/h land comprising the shopping centre winsford cheshire t/n's CH287801, CH38458 and CH356569 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon and assigns the goodwill of the business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of rents | Erstellt am 30. Sept. 1996 Geliefert am 10. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assignment of the benefit of all rents, licence or tenancy fees payable by any lessee, licence or tenant of any part of the shopping centre winsford cheshire (as defined in the mortgage deed of even date). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fourth supplemental trust deed | Erstellt am 29. Sept. 1995 Geliefert am 04. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben Freehold property known as land and buildings lying to the east of derby road,huyton,merseyside title number MS291314 and a floating charge over all property assets including any uncalled capital and all monies payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 29. Nov. 1994 Geliefert am 12. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Acquisition of property | Erstellt am 12. Nov. 1994 Erworben am 25. Okt. 1994 Geliefert am 12. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £7,850,000 | |
Kurze Angaben Lancaster house 36 orchard street lincoln t/no LL46183. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Acquisition of property | Erstellt am 12. Nov. 1994 Erworben am 25. Okt. 1994 Geliefert am 12. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £7,850,000 | |
Kurze Angaben Winsford town centre cheshire t/no CH287801. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| "C" loan notes charge | Erstellt am 08. Nov. 1994 Erworben am 25. Okt. 1994 Geliefert am 08. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben 179 high street lincoln t/no LL27733. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| "C" loan notes charge | Erstellt am 08. Nov. 1994 Erworben am 25. Okt. 1994 Geliefert am 08. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due | |
Kurze Angaben F/H property k/a lancaster house lincoln t/no LL46183 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Sept. 1988 Erworben am 14. Juni 1995 Geliefert am 04. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £6,850,000.00 | |
Kurze Angaben Land and buildings at queens parade fountain court and dingle walk winsford cheshire t/n-CH287801, CH384588 and CH356569. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0