CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02955679 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| M&R 610 LIMITED | 04. Aug. 1994 | 04. Aug. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 94 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
legacy | 92 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 97 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | 151008680001 | |||||||
| DUNN, Robert Dominic | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 179134020002 | |||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 182167230001 | |||||
| ASHBURNER, Ronald Leslie George | Sekretär | 5 The Avenue UB10 8NR Uxbridge Middlesex | British | 102503610001 | ||||||
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | 148 Selwyn Avenue Highams Park E4 9LS London | British | 72139660001 | ||||||
| LUBASCH, Richard Joel | Sekretär | 4 Beech Tree Lane NEW YORK Brookville 11545 Usa | British | 81075820001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | 47785600002 | ||||||
| MARSHALL, Brian | Sekretär | 112 Hills Road CB2 1PH Cambridge | British | 76205930002 | ||||||
| PROCTOR, Martina | Sekretär | 37a Madingley Road CB3 0EL Cambridge | British | 43777590001 | ||||||
| RYAN, Paul | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Silver Street CB7 4JF Ely Cambridgeshire | British | 900010140001 | ||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| ALDEN, Peter James | Geschäftsführer | 32 Brookside CB2 1JQ Cambridge | British | 40967330002 | ||||||
| CAMPBELL, Gerald Daniel | Geschäftsführer | 18 Ringwood Avenue N2 9NS London | American | 48066760001 | ||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||
| CHEW, Mun Chun | Geschäftsführer | 15 Rectory Farm Road Little Wilbraham CB1 5LB Cambridge | Singaporean | 36124880001 | ||||||
| DAVENPORT, Hugo Riddell Agard Bramhall | Geschäftsführer | 19 Wingate Way CB2 2HD Cambridge Cambridgeshire | British | 6298250001 | ||||||
| DAVIES, Richard James | Geschäftsführer | The Library Suite The Mansion KT16 0QB Ottershaw Park Surrey | American | 45182540001 | ||||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | England | British | 96956740001 | |||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Station Road KT7 0NS Thames Ditton 42 Surrey | England | British | 96956740001 | |||||
| GOWEN, Wayne Lyle | Geschäftsführer | New House Fairoak Lane Oxshott KT22 0TP Leatherhead Surrey | British | 39694410001 | ||||||
| GREGG, John Francis | Geschäftsführer | 411 Silvermoss Drive Vero Beach Florida 32963 America | American | 75381740001 | ||||||
| HO, Lam Phoh | Geschäftsführer | 129 Tanah Kerah Kechill Road 1646 Singapore | Singaporean | 36156430001 | ||||||
| KELHAM, David William | Geschäftsführer | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | 87146390001 | |||||
| KNAPP, James Barclay | Geschäftsführer | 54 Hodge Road Princeton New Jersey 08540 Usa | Us Citizen | 79688880001 | ||||||
| LAWLEY, Ronald Edward | Geschäftsführer | 28 Hurst Park GU29 0BP Midhurst West Sussex | United Kingdom | British | 121475980001 | |||||
| LEW, Allen Yoong Keong | Geschäftsführer | 52 Nallur Road Singapore 1545 | Singaporean | 44257660001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MARSHALL, Brian | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Owls Hall Chimney Street Hundon CO10 8DX Sudbury Suffolk | British | 900008320001 | ||||||
| MCKELLAR, Ronald Alexander | Geschäftsführer | Halstead Stratfield Saye RG7 2EJ Reading Berkshire | British | 7345780001 | ||||||
| MIZGA, Gary Lamont | Geschäftsführer | Nuthatch Prey Heath Common Mayford GU22 0SL Woking Surrey | Usa | 55553500001 | ||||||
| RICHTER, Bret | Geschäftsführer | 245 East 63rd Street Apartment 20h 10021 New York New York United States | American | 86830760001 | ||||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Geschäftsführer | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||
| ROSS, Stuart | Geschäftsführer | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 |
Hat CCL CORPORATE COMMUNICATION SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 29. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An alternative bridge composite debenture | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 29. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 10. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0