LANNISPORT BRISTOL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLANNISPORT BRISTOL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02957592
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?

    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich LANNISPORT BRISTOL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BEG LIMITED18. Sept. 200618. Sept. 2006
    BUSINESS ENVIRONMENT GROUP LIMITED20. Jan. 199820. Jan. 1998
    SIRENSTORM LIMITED11. Aug. 199411. Aug. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für LANNISPORT BRISTOL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    22 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Mai 2020

    16 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom zum 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 31. Mai 2019

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Haysmacintyre Company Secretaries Limited als Sekretär am 28. Apr. 2019

    2 SeitenTM02

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Mai 2019

    LRESEX

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Change of details for Lannisport Limited as a person with significant control on 18. Dez. 2017

    2 SeitenPSC05

    Änderung der Details des Sekretärs für Haysmacintyre Company Secretaries Limited am 18. Dez. 2017

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom zum 10 Queen Street Place London EC4R 1AG am 18. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    15 SeitenAA

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 150 Minories London EC3N 1LS zum Central Point 45 Beech Street London EC2Y 8AD geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 07. Aug. 2017

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    22 SeitenAA

    Ernennung von Haysmacintyre Company Secretaries Limited als Sekretär am 16. Aug. 2016

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Simon Michael Rusk als Sekretär am 16. Aug. 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Jayson Jenkins als Sekretär am 18. Aug. 2016

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 22. Juni 2016

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 15. März 2016

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 14. März 2016

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILBERT, Melvyn Stephen, Mr
    45 Beech Street
    EC2Y 8AD London
    Central Point
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Beech Street
    EC2Y 8AD London
    Central Point
    United Kingdom
    United KingdomBritish6395630003
    JENKINS, Jayson
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    Sekretär
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    165660540001
    KLUG, Bernard Philip
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    Sekretär
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    British15387060001
    RUSK, Simon Michael, Mr.
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    Sekretär
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    British123853770003
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Sekretär
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer4682161
    89121630002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    EMDEN, Andrew Marc
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish126685040002
    GANDY, Nicolas Sean
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    Geschäftsführer
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United KingdomBritish135709440001
    GERSHINSON, Colin Anthony
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish21890030001
    GLAZER, David Anthony
    No 1 Cecil Road
    Muswell Hill
    N10 2BU London
    Geschäftsführer
    No 1 Cecil Road
    Muswell Hill
    N10 2BU London
    British40730610002
    HEFFERMAN, Graham Anthony
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish140993530001
    JENKINS, Jayson
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish126305070001
    KLUG, Bernard Philip
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    EnglandBritish15387060004
    KLUG, Bernard Philip
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    Geschäftsführer
    57 Sheldon Avenue
    N6 4NH London
    British15387060001
    MERCER, Graham Paul
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Groveland Court
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish108922930002
    RUSK, Simon Michael
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish123853770004
    SAUL, David Gary
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Minories
    EC3N 1LS London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish57597480002
    STEWART, Andrew Lawrence
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12 Groveland Court
    Geschäftsführer
    Bow Lane
    EC4M 9EH London
    12 Groveland Court
    United KingdomBritish23329410002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LANNISPORT BRISTOL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05721962
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat LANNISPORT BRISTOL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. März 2006
    Geliefert am 08. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Leeds Building Society
    Transaktionen
    • 08. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordination deed
    Erstellt am 05. Sept. 2005
    Geliefert am 07. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from ravencap (no.2) limited to the chargeee on any account whatsoever and all monies due or to become due from ravencap (no.2) limited to the subordinated creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    If any amount of subordinated liabilities is descharged or purported to be discharged by payment, repayment, prepayment, set-off or in any immediately pay it to the agent and pay to the agent an amount equal. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 13. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cash of £152,500.00.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Trust Company (Jersey) Limited & Rbsi Trust Company Limited (Astrustees of the Schroder Emerging Retail Property Unit Trust)
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge deed
    Erstellt am 31. Okt. 2002
    Geliefert am 06. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from business environment basingstoke limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property being those land and buildings k/a viewpoint (formerly berk house) basing view basingstoke hampshire t/no HP202491 and the fixtures. By way of fixed charge all the income, the proceeds of disposal and all deeds and documents, the equipment and goods and assigns the related rights.
    Berechtigte Personen
    • Leeds & Holbeck Building Society
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Feb. 2001
    Geliefert am 05. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever as agreed in a facility letter dated 26 february 2001
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a newton house 101-113 pentonville road london t/n LN89223; the l/h property k/a view point (formerly berk house) basing view basingstoke hampshire t/n HP202491. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 2001
    Geliefert am 05. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Floating charge all undertaking and assets of the company present and future.
    Berechtigte Personen
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transaktionen
    • 05. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of rental assignment
    Erstellt am 15. Feb. 2001
    Geliefert am 20. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from valleyplace properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The right title benefit and interest (whether present or future) in the rent licence fees or other sums of money.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 2001
    Geliefert am 20. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from valleyplace property limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property k/a part ground and first-fourth floors, 3-10 market place, reading t/n BK366695. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge deed
    Erstellt am 13. Apr. 2000
    Geliefert am 03. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    70 to 78 (even) queens road,clifton,bristol together with all buildings thereon and all fixtures subject to and with the benefit of all rights,easements,covenants,restrictions stipulations,agreements,declarations and other matters affecting and/or benefiting the same including every part of the same.specific charge all the income from time to time arising or payable to or on behalf of the company in relation to the property. Assigned to the lender the related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge deed
    Erstellt am 29. Sept. 1999
    Geliefert am 07. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Berk house basing view basingstoke and all fixtures, related rights, fixtures fittings plant and machinery thereon asigns the goodwill and intellectual property. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Mai 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a southbank house black prince road l/b of lambeth greater london t/no: LN141960 and the goodwill of the business the benefit of the licences and the benefits respectively carried on or arising in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 28. Mai 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of the company in connection with the letting of international life house 1 olympic way wembley l/b of brent greater london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 28. Mai 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of the company in connection with the letting of southbank house black prince road l/b of lambeth greater london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Mai 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Mai 1999
    Geliefert am 09. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a international life house 1 olympic way wembley l/b of brent greater london t/no: NGL46390 and the goodwill of the business the benefit of licences and the benefits carried on or arising in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Aug. 1997
    Geliefert am 22. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 1 olympic way wembley london t/no: NGL46390 by way of fixed charge all rental income present or future floating charge over. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed of debenture (the "supplemental debenture") which amends the debenture executed on 31ST october 1994 (the "original debenture")
    Erstellt am 27. Feb. 1996
    Geliefert am 15. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee of specific liabilities executed by the company on 1ST march 1996 to guarantee the obligations of london and regional property investments limited ("lrpi") under a facility agreement dated 1ST march 1996 entered into between "lrpi" and the bank
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irsih Bank Coporation PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee, indemnity and security assignment agreement
    Erstellt am 26. Apr. 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement
    Kurze Angaben
    1. all right to and interest in the goods or other assets subject of the finance lease agreement numbered 134554 dated 26/04/95 2. all the right, title, benefit and interest in and to the finance lease agreement. 3. all other rights and benefits in the above. 4. all rights to sue for damage.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Okt. 1994
    Geliefert am 10. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at southbank house black prince road london SE1 t/n ln 141960 and f/h property k/a 81/103 (odd) euston street and 1/6 regnart buildings london NW1 t/n ngl 236815. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 31. Okt. 1994
    Geliefert am 05. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Property being the land and buildings at southbank house, black prince road, london SE1 t/no. LN141960 and all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon and any proceeds of any insurance of the property.
    Berechtigte Personen
    • Serviced Businesses (Southbank) Limited
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 31. Okt. 1994
    Geliefert am 05. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    Property being land and buildings k/a 81/103 (odd numbers) euston street and 1/6 regnart buildings, london NW1 t/no. NGL236815 and all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon and any proceeds of any insurance of the property.
    Berechtigte Personen
    • Serviced Businesses (Southbank) Limited
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LANNISPORT BRISTOL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Mai 2019Beginn der Liquidation
    26. Aug. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Lewis Armstrong
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Geoffrey Paul Rowley
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0