LANNISPORT BRISTOL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LANNISPORT BRISTOL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02957592 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich LANNISPORT BRISTOL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor 110 Cannon Street EC4N 6EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BEG LIMITED | 18. Sept. 2006 | 18. Sept. 2006 |
| BUSINESS ENVIRONMENT GROUP LIMITED | 20. Jan. 1998 | 20. Jan. 1998 |
| SIRENSTORM LIMITED | 11. Aug. 1994 | 11. Aug. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LANNISPORT BRISTOL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 22 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Mai 2020 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom zum 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 31. Mai 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Haysmacintyre Company Secretaries Limited als Sekretär am 28. Apr. 2019 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Lannisport Limited as a person with significant control on 18. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Haysmacintyre Company Secretaries Limited am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom zum 10 Queen Street Place London EC4R 1AG am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 150 Minories London EC3N 1LS zum Central Point 45 Beech Street London EC2Y 8AD geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 07. Aug. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Haysmacintyre Company Secretaries Limited als Sekretär am 16. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Michael Rusk als Sekretär am 16. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jayson Jenkins als Sekretär am 18. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 22. Juni 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 15. März 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Melvyn Stephen Gilbert am 14. März 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LANNISPORT BRISTOL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERT, Melvyn Stephen, Mr | Geschäftsführer | 45 Beech Street EC2Y 8AD London Central Point United Kingdom | United Kingdom | British | 6395630003 | |||||||||
| JENKINS, Jayson | Sekretär | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | 165660540001 | |||||||||||
| KLUG, Bernard Philip | Sekretär | 57 Sheldon Avenue N6 4NH London | British | 15387060001 | ||||||||||
| RUSK, Simon Michael, Mr. | Sekretär | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | British | 123853770003 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
| EMDEN, Andrew Marc | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 126685040002 | |||||||||
| GANDY, Nicolas Sean | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 135709440001 | |||||||||
| GERSHINSON, Colin Anthony | Geschäftsführer | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | United Kingdom | British | 21890030001 | |||||||||
| GLAZER, David Anthony | Geschäftsführer | No 1 Cecil Road Muswell Hill N10 2BU London | British | 40730610002 | ||||||||||
| HEFFERMAN, Graham Anthony | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 140993530001 | |||||||||
| JENKINS, Jayson | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 126305070001 | |||||||||
| KLUG, Bernard Philip | Geschäftsführer | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | England | British | 15387060004 | |||||||||
| KLUG, Bernard Philip | Geschäftsführer | 57 Sheldon Avenue N6 4NH London | British | 15387060001 | ||||||||||
| MERCER, Graham Paul | Geschäftsführer | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 United Kingdom | England | British | 108922930002 | |||||||||
| RUSK, Simon Michael | Geschäftsführer | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | United Kingdom | British | 123853770004 | |||||||||
| SAUL, David Gary | Geschäftsführer | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | United Kingdom | British | 57597480002 | |||||||||
| STEWART, Andrew Lawrence | Geschäftsführer | Bow Lane EC4M 9EH London 12 Groveland Court | United Kingdom | British | 23329410002 | |||||||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LANNISPORT BRISTOL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lannisport Limited | 06. Apr. 2016 | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LANNISPORT BRISTOL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. März 2006 Geliefert am 08. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Subordination deed | Erstellt am 05. Sept. 2005 Geliefert am 07. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ravencap (no.2) limited to the chargeee on any account whatsoever and all monies due or to become due from ravencap (no.2) limited to the subordinated creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben If any amount of subordinated liabilities is descharged or purported to be discharged by payment, repayment, prepayment, set-off or in any immediately pay it to the agent and pay to the agent an amount equal. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 08. Nov. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Cash of £152,500.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 31. Okt. 2002 Geliefert am 06. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from business environment basingstoke limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property being those land and buildings k/a viewpoint (formerly berk house) basing view basingstoke hampshire t/no HP202491 and the fixtures. By way of fixed charge all the income, the proceeds of disposal and all deeds and documents, the equipment and goods and assigns the related rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Feb. 2001 Geliefert am 05. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever as agreed in a facility letter dated 26 february 2001 | |
Kurze Angaben The f/h property k/a newton house 101-113 pentonville road london t/n LN89223; the l/h property k/a view point (formerly berk house) basing view basingstoke hampshire t/n HP202491. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Feb. 2001 Geliefert am 05. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Floating charge all undertaking and assets of the company present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rental assignment | Erstellt am 15. Feb. 2001 Geliefert am 20. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from valleyplace properties limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The right title benefit and interest (whether present or future) in the rent licence fees or other sums of money. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Feb. 2001 Geliefert am 20. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from valleyplace property limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property k/a part ground and first-fourth floors, 3-10 market place, reading t/n BK366695. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 13. Apr. 2000 Geliefert am 03. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 70 to 78 (even) queens road,clifton,bristol together with all buildings thereon and all fixtures subject to and with the benefit of all rights,easements,covenants,restrictions stipulations,agreements,declarations and other matters affecting and/or benefiting the same including every part of the same.specific charge all the income from time to time arising or payable to or on behalf of the company in relation to the property. Assigned to the lender the related rights.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 29. Sept. 1999 Geliefert am 07. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Berk house basing view basingstoke and all fixtures, related rights, fixtures fittings plant and machinery thereon asigns the goodwill and intellectual property. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Mai 1999 Geliefert am 09. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a southbank house black prince road l/b of lambeth greater london t/no: LN141960 and the goodwill of the business the benefit of the licences and the benefits respectively carried on or arising in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of rental income | Erstellt am 28. Mai 1999 Geliefert am 09. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of the company in connection with the letting of international life house 1 olympic way wembley l/b of brent greater london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of rental income | Erstellt am 28. Mai 1999 Geliefert am 09. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of the company in connection with the letting of southbank house black prince road l/b of lambeth greater london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Mai 1999 Geliefert am 09. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Mai 1999 Geliefert am 09. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a international life house 1 olympic way wembley l/b of brent greater london t/no: NGL46390 and the goodwill of the business the benefit of licences and the benefits carried on or arising in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Aug. 1997 Geliefert am 22. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 1 olympic way wembley london t/no: NGL46390 by way of fixed charge all rental income present or future floating charge over. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of debenture (the "supplemental debenture") which amends the debenture executed on 31ST october 1994 (the "original debenture") | Erstellt am 27. Feb. 1996 Geliefert am 15. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee of specific liabilities executed by the company on 1ST march 1996 to guarantee the obligations of london and regional property investments limited ("lrpi") under a facility agreement dated 1ST march 1996 entered into between "lrpi" and the bank | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee, indemnity and security assignment agreement | Erstellt am 26. Apr. 1995 Geliefert am 16. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement | |
Kurze Angaben 1. all right to and interest in the goods or other assets subject of the finance lease agreement numbered 134554 dated 26/04/95 2. all the right, title, benefit and interest in and to the finance lease agreement. 3. all other rights and benefits in the above. 4. all rights to sue for damage. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Okt. 1994 Geliefert am 10. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings at southbank house black prince road london SE1 t/n ln 141960 and f/h property k/a 81/103 (odd) euston street and 1/6 regnart buildings london NW1 t/n ngl 236815. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 31. Okt. 1994 Geliefert am 05. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Property being the land and buildings at southbank house, black prince road, london SE1 t/no. LN141960 and all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon and any proceeds of any insurance of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 31. Okt. 1994 Geliefert am 05. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben Property being land and buildings k/a 81/103 (odd numbers) euston street and 1/6 regnart buildings, london NW1 t/no. NGL236815 and all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon and any proceeds of any insurance of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LANNISPORT BRISTOL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0