ASHBOURNE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASHBOURNE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02958151
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASHBOURNE LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich ASHBOURNE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ASHBOURNE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ASHBOURNE GROUP UK LIMITED08. März 200108. März 2001
    SUN HEALTHCARE GROUP UK LIMITED 22. Jan. 199922. Jan. 1999
    SUN HEALTHCARE GROUP INTERNATIONAL LTD.30. Aug. 199430. Aug. 1994
    BASICTOP LIMITED12. Aug. 199412. Aug. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASHBOURNE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASHBOURNE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 18. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 136,232,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    21 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    11 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    12 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    18 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von ASHBOURNE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    BROUSSARD, Bruce Dale
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    Sekretär
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    American40571230001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Sekretär
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Sekretär
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Sekretär
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Sekretär
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304820001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Sekretär
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    WIMER, Mark G
    7939 West Bayhill Court
    83704 Boise
    Idaho
    Usa
    Sekretär
    7939 West Bayhill Court
    83704 Boise
    Idaho
    Usa
    American52192900001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Geschäftsführer
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BROUSSARD, Bruce Dale
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    Geschäftsführer
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    American40571230001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Geschäftsführer
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Geschäftsführer
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Geschäftsführer
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Geschäftsführer
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Geschäftsführer
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Geschäftsführer
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Geschäftsführer
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PHIPPEN, Kent William
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    Geschäftsführer
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    United KingdomAmerican84576560001

    Hat ASHBOURNE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Share charge
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 14. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights, existing shares means ordinary shares of £0.10, number of existing shares 53,648,599. related rights means all dividends see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 14. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 14. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 14. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Share charge
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share charge
    Erstellt am 07. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its whole right title and interest and benefit in and to the existing shares and related rights any additional shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share pledge
    Erstellt am 02. Dez. 2005
    Geliefert am 15. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 02. Dez. 2005
    Geliefert am 15. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 01. Apr. 2005
    Geliefert am 19. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever or all monies due or to become due from cannon capital ventures limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share pledge
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares (53,648,599 ordinary shares of £0.10 each in the company, any future shares) and all related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 10. Feb. 2005
    Geliefert am 24. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and cannon capital ventures limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property now owned by it, and all buildings and fixtures and fixed plant and fixed machinery, all of its book and other debts, any know-how, patent, trade mark, service mark, design, business name, any copyright or other intellectual property monopoly right. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors(The Security Agent)
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ASHBOURNE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0