PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02963711 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Aktivitäten von Zeitarbeitsagenturen (78200) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PREMIERE EMPLOYMENT LIMITED | 03. Jan. 1995 | 03. Jan. 1995 |
| PREMIERE EMPLOYMENT GROUP LIMITED | 11. Nov. 1994 | 11. Nov. 1994 |
| QUOTEDIRECT LIMITED | 31. Aug. 1994 | 31. Aug. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Beendigung der Bestellung von Jack Rainer Ullmann als Geschäftsführer am 12. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 029637110010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Beendigung der Bestellung von Chris Martin Kenneally als Geschäftsführer am 16. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Erfüllung der Belastung 029637110011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Ernennung von Mr Alan Connor als Sekretär am 05. März 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr Chris Martin Kenneally als Direktor am 05. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Connor als Sekretär am 05. März 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Chris Martin Kenneally als Geschäftsführer am 05. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 31. Dez. 2016 | 8 Seiten | AAMD | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2016 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||
Eintragung der Belastung 029637110011, erstellt am 03. Nov. 2016 | 70 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 029637110010, erstellt am 15. Aug. 2016 | 45 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNOR, Alan | Sekretär | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | 267882580001 | |||||||
| ULLMANN, Phillip Lionel | Geschäftsführer | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | England | British | 46458480002 | |||||
| BELCHEM, Gary | Sekretär | 17 Turkey Oak Close Upper Norwood SE19 2NZ London | British | 66391670002 | ||||||
| CONNOR, Alan | Sekretär | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | British | 118003220001 | ||||||
| GARRATT, Mark Jonathan | Sekretär | 21 Stradella Road Herne Hill SE24 9HN London | British | 118003050001 | ||||||
| MARKS, Dorian Alan | Sekretär | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | 94546740001 | ||||||
| MARKS, Dorian Alan | Sekretär | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | 94546740001 | ||||||
| MILLER, David | Sekretär | 3 Worsdell Way SG4 0EB Hitchin Hertfordshire | British | 59650030004 | ||||||
| TAYLOR, Michael John | Sekretär | 6 Garratts Lane SM7 2DZ Banstead Surrey | British | 64380001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED | Sekretär | Wacks Caller Steam Packet House 76 Cross Street M2 4JU Manchester | 77050230003 | |||||||
| BLEASDALE, Kathleen Veronica | Geschäftsführer | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 67650680001 | |||||
| CARISS, John Stuart | Geschäftsführer | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 69554890001 | |||||
| CHAPMAN, Clive Richard | Geschäftsführer | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | United Kingdom | British | 86129050001 | |||||
| DURSTON, Robert | Geschäftsführer | 13 Roundell Road BB18 6EB Barnoldswick Lancashire | British | 110017830001 | ||||||
| HALLIDAY, Steven Don | Geschäftsführer | Laneside Wallbank Road Bramhall SK7 3AP Stockport Cheshire | England | British | 61413670001 | |||||
| KENNEALLY, Chris Martin | Geschäftsführer | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | Wales | British | 267876240001 | |||||
| KENNEALLY, Chris Martin | Geschäftsführer | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | Wales | British | 267876240001 | |||||
| KIRKPATRICK, Steven William | Geschäftsführer | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | Northern Ireland | Northern Irish | 185295780002 | |||||
| MARKS, Dorian Alan | Geschäftsführer | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | 94546740001 | ||||||
| MARKS, Dorian Alan | Geschäftsführer | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | 94546740001 | ||||||
| O'BRIEN, Fergal | Geschäftsführer | 79 Hermitage Road WA15 8BW Hale Cheshire | Irish | 78893160002 | ||||||
| O'BRIEN, Fergal | Geschäftsführer | 79 Hermitage Road WA15 8BW Hale Cheshire | Irish | 78893160002 | ||||||
| PERCIVAL, Lorraine Elizabeth | Geschäftsführer | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | United Kingdom | British | 85413680001 | |||||
| PILGRIM, Alan John Templer | Geschäftsführer | 44 Pepper Hill Great Amwell SG12 9RZ Ware Hertfordshire | England | British | 11755290002 | |||||
| PINDER, John Richard | Geschäftsführer | West Pelham Manor Park BR7 5QE Chislehurst Kent | British | 78379030001 | ||||||
| ULLMANN, Jack Rainer | Geschäftsführer | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | England | British | 11342820001 | |||||
| ULLMANN, Marianne Flora | Geschäftsführer | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingson Middlesex | England | British | 6228260001 | |||||
| WILLIAMSON, Lynda | Geschäftsführer | 277 Hardsough Lane Irwell Vale Ewood Bridge BL0 0QF Rossendale Lancashire | British | 39140490001 | ||||||
| WILLIAMSON, Mark | Geschäftsführer | 94 Ringley Road Whitefield M45 7UV Manchester | British | 64862020001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| WACKS CALLER LIMITED | Geschäftsführer | Wacks Caller Steam Packet House 76 Cross Street M2 4JU Manchester | 58396030003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordant Procurement Recruitment Limited | 06. Apr. 2016 | Long Lane Hillingdon UB10 9PF Uxbridge Chevron House Middlesex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PAYROLL SPECIALIST SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2016 Geliefert am 07. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the debenture dated 3 march 2014. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 15. Aug. 2016 Geliefert am 15. Aug. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2011 Geliefert am 28. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2011 Geliefert am 27. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed to a debenture originally dated 14 june 2007 and | Erstellt am 05. Aug. 2009 Geliefert am 19. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and from the chargors to rbs invoice finance limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, investments. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Apr. 2007 Geliefert am 12. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 07. Jan. 2000 Geliefert am 26. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 18. Aug. 1999 Geliefert am 25. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Aug. 1998 Geliefert am 12. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 22. Dez. 1997 Geliefert am 09. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. März 1995 Geliefert am 10. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0