CATLIN UNDERWRITING
Überblick
| Unternehmensname | CATLIN UNDERWRITING |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 02966836 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CATLIN UNDERWRITING?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich CATLIN UNDERWRITING?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CATLIN UNDERWRITING?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CATLIN UNDERWRITING PLC | 04. Juni 2007 | 04. Juni 2007 |
| WELLINGTON UNDERWRITING PLC | 06. Sept. 1994 | 06. Sept. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CATLIN UNDERWRITING?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CATLIN UNDERWRITING?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG zum 30 Finsbury Square London EC2A 1AG am 30. Sept. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher John Read als Direktor am 05. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Richard Bradbrook als Geschäftsführer am 05. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Craig Standen als Direktor am 17. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Juliet Phillips als Geschäftsführer am 17. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrew Jardine als Geschäftsführer am 26. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Clynton Jacobus Luttig als Direktor am 26. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Juliet Phillips als Direktor am 26. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Cessation of Xl Group Ltd as a person with significant control on 12. Sept. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Axa Sa as a person with significant control on 12. Sept. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CATLIN UNDERWRITING?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REES, Marie Louise | Sekretär | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | 201064360001 | |||||||
| LUTTIG, Clynton Jacobus | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | England | British | 218565170001 | |||||
| READ, Christopher John | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | 267508980001 | |||||
| STANDEN, Craig | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | 265497100001 | |||||
| BUSHER, Thomas George Story | Sekretär | Manor Farm Cottage School Hill Soberton SO32 3PF Southampton Hampshire | British | 6386010002 | ||||||
| GLOVER, Michael Logan | Sekretär | Dunelm 41. St. Catherines Road EN10 7LD Broxbourne Herts | British | 94249710001 | ||||||
| GRAHAM, Nicola Geraldine | Sekretär | Gracechurch Street EC3V 0BG London 20 United Kingdom | British | 122081730001 | ||||||
| NOONE, Lisa Marie | Sekretär | 8 Paget Road IP1 3RP Ipswich Suffolk | British | 72182310002 | ||||||
| THOMAS, Heather Irene | Sekretär | 5 Lambert Jones Mews Barbican EC2Y 8DP London | British | 105936240001 | ||||||
| NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | Sekretär | 76 George Street EH2 3BU Edinburgh | 94907480001 | |||||||
| AGNEW, Ian Charles | Geschäftsführer | 23 Chalfont House 19 Chesham Street SW1X 8NG London | British | 6418620003 | ||||||
| AVERY, Julian Ralph | Geschäftsführer | Little Boarzell Hurst Green TN19 7QU Etchingham East Sussex | United Kingdom | Uk | 37578750001 | |||||
| BARTON, Robert John Orr | Geschäftsführer | 33 Rutland Court Rutland Gardens SW7 1BW London | British | 7999080003 | ||||||
| BRADBROOK, Paul Richard | Geschäftsführer | Gracechurch Street EC3V 0BG London 20 | United Kingdom | British | 148983260001 | |||||
| BURKE, Martin Thomas | Geschäftsführer | Albany, 26 Leafy Way Hutton CM13 2QW Brentwood Essex | United Kingdom | Irish | 240344510001 | |||||
| BURROWS, Timothy William | Geschäftsführer | 37 Northumberland Road New Barnet EN5 1EB Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 126815810002 | |||||
| BUSHER, Thomas George Story | Geschäftsführer | Manor Farm Cottage School Hill Soberton SO32 3PF Southampton Hampshire | British | 6386010002 | ||||||
| CALLAN, Robert | Geschäftsführer | Gracechurch Street EC3V 0BG London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 130365420001 | |||||
| CUSACK, Julian Michael | Geschäftsführer | 3 Eastern Close Rushmere St. Andrew IP4 5BY Ipswich Suffolk | British | 84410430001 | ||||||
| DUMAS, Henry Raymond | Geschäftsführer | Coldharbour Farm BS30 5RJ Wick South Gloucestershire | British | 73016630001 | ||||||
| ENGESTROM, John | Geschäftsführer | Yardley Farm Chequers Lane LU7 9AG Pitstone Buckinghamshire | Swedish | 67286160004 | ||||||
| FOREMAN, David Peter | Geschäftsführer | Ringers Farm Russ Hill Road Charlwood RH6 0EW Horley Surrey | England | British | 121083690001 | |||||
| FRESHWATER, Neil Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Gracechurch Street EC3V 0BG London 20 United Kingdom | England | British | 125646370001 | |||||
| FULKERSON, Allan White | Geschäftsführer | P.O.Box 149 Center Sandwich 03227 New Hampshire Usa | Usa | 62315920001 | ||||||
| GEFERS, Robert Bruce | Geschäftsführer | 34 Stokenchurch Street SW6 3TR London | American | 61931140001 | ||||||
| HAMILTON, Paul Richard | Geschäftsführer | Hole Farm Wilderness Lane TN22 4HB Hadlow Down East Sussex | United Kingdom | British | 84274310001 | |||||
| HANCE, Julian Christopher | Geschäftsführer | Brackenfell South Bank BN6 8JP Hassocks West Sussex | United Kingdom | British | 40271690002 | |||||
| HAYNES, Joseph Antony | Geschäftsführer | 40 Edwardes Square W8 6HH London | British | 9580170001 | ||||||
| HEFTI, Wilhelm Hendrik | Geschäftsführer | St Georgenstrasse 41 Ch 8400 Winterthur Switzerland | Swiss | 84654940001 | ||||||
| IBESON, David Christopher Ben | Geschäftsführer | Gracechurch Street EC3V 0BG London 20 United Kingdom | United Kingdom | British | 52745170002 | |||||
| JARDINE, Paul Andrew | Geschäftsführer | Gracechurch Street EC3V 0BG London 20 United Kingdom | England | British | 62337170003 | |||||
| LETSINGER, Katherine Lee | Geschäftsführer | 55 Northumberland Place W2 5AS London | United Kingdom | British | 54716770009 | |||||
| MAXWELL, John Hunter | Geschäftsführer | 17 Cliveden Place SW1W 8LA London | British | 86357670001 | ||||||
| O'KANE, Charles Christopher | Geschäftsführer | 107 Albert Street NW1 7NB London | United Kingdom | British | 61931210002 | |||||
| PHILLIPS, Juliet | Geschäftsführer | Gracechurch Street EC3V 0BG London 20 | United Kingdom | British | 211555110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CATLIN UNDERWRITING?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa Sa | 12. Sept. 2018 | Avenue Matignon 75008 Paris 25 France | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Xl Group Ltd | 25. Juli 2016 | One Bermudiana Road HM08 Hamilton O'Hara House Bermuda | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Xl Group Plc | 06. Apr. 2016 | 8 St. Stephens Green Dublin 2 Xl House Ireland | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CATLIN UNDERWRITING Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 19. März 2007 Geliefert am 28. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 11. Dez. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other banks under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all the right title and interest in to and under the charged property and all of the companys right title and interest in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Dez. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 11. Dez. 2003 Geliefert am 19. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the assignee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All or its right, title and interest, present and future, in, under and to the contract including, without limitation, all present and future claims, causes of action, payments and proceeds in respect thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Aug. 1998 Geliefert am 27. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Juli 1997 Geliefert am 29. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Apr. 1997 Geliefert am 23. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CATLIN UNDERWRITING Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0