ROXBURGH FOXHILLS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROXBURGH FOXHILLS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02967549 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROXBURGH FOXHILLS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich ROXBURGH FOXHILLS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Avnet House Rutherford Close Meadway SG1 2EF Stevenage Hertfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROXBURGH FOXHILLS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROXBURGH FOXHILLS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Raymond Sadowski als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Birk als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Abacus House Bone Lane Newbury Berks RG14 5SF am 19. Jan. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROXBURGH FOXHILLS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN DER ZWALMEN, Anne | Sekretär | Grimbergen Helman De Grimberghelaan 28 1850 Belgium | Belgian | 138188190001 | ||||||
| BIELEFELD, Peter | Geschäftsführer | Guckingen Im Vordern Boden 25 65558 Germany | Germany | German | 138187960001 | |||||
| ZAMMIT, Patrick Laurent | Geschäftsführer | Avenue Du Manoir 38 B-1180 Brussels 1180 Belgium | Belgium | French | 114841080001 | |||||
| BATEMAN, Andrew | Sekretär | 34 Heath Close RG41 2PG Wokingham Berkshire | British | 24432680002 | ||||||
| HEFFERNAN, Liam Anthony | Sekretär | 5 Malthouse Meadows GU30 7BD Liphook Hampshire | British | 100478700001 | ||||||
| RALPH, George Alexander | Sekretär | Great North Road Eaton Ford PE19 7FP St. Neots 367 Cambridgeshire | British | 184012200001 | ||||||
| TOZER, Richard Edward | Sekretär | Lodge Farm Elmdon CB11 4LU Saffron Walden Essex | British | 2236800001 | ||||||
| VAN DER PANT, Gavin Lawrence | Sekretär | 9 Westfield Cottages Henley Road SL7 2HQ Medmenham Buckinghamshire | British | 72310190001 | ||||||
| WHATLEY, Michael Christopher | Sekretär | Dovedon Hall Whepstead IP29 4UB Bury St Edmunds Suffolk | British | 14021910001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALLEN, Peter Vance | Geschäftsführer | Buckholm Mill TD1 2HB Galashields Selkirkshire | Great Britain | British | 3711280004 | |||||
| BIRK, David Ralph, Mr. | Geschäftsführer | East Corrine Drive Scottsdale Arizona 12983 Az 85259 United States | Usa | American | 136282980001 | |||||
| KENT, Martin Robert | Geschäftsführer | Ridgebourne Front Street, East Garston RG17 7EU Hungerford Berkshire | British | 6391620007 | ||||||
| O'NEILL, Derek Patrick | Geschäftsführer | Oakley House, Verley Close Woughton On The Green MK6 3ER Milton Keynes | England | British | 87909140001 | |||||
| SADOWSKI, Raymond John | Geschäftsführer | 13120 East Appaloosa Place Scottsdale Arizona 85259 Az Usa | Usa | American | 143504560001 | |||||
| SAWYER, Christopher John | Geschäftsführer | East House Plumpton Whepstead IP29 4SU Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 234740930001 | |||||
| TOZER, Richard Edward | Geschäftsführer | Lodge Farm Elmdon CB11 4LU Saffron Walden Essex | British | 2236800001 |
Hat ROXBURGH FOXHILLS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Sept. 2001 Geliefert am 01. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 27. Juni 2001 Geliefert am 13. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 09. Nov. 1999 Geliefert am 17. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Nov. 1999 Geliefert am 16. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage f/h roxburgh house foxhills industrial park scunthorpe t/n-HS239235. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. März 1997 Geliefert am 26. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys now due or to become due from deltron electronics PLC to the chargee on any account whatsoever and by the company pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben Plot 3D & land at plot 3C atinsons way foxhills industrial park scunthorpe benefit of all rights licences contracts deeds undertaings and the assigns of goodwill to the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 04. Okt. 1994 Geliefert am 18. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1994 Geliefert am 01. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0