WATES CITY POINT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWATES CITY POINT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02973114
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WATES CITY POINT LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich WATES CITY POINT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WATES CITY POINT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NUMBER 27/35 CANNON STREET LIMITED27. Jan. 199527. Jan. 1995
    BISHOLD LIMITED03. Okt. 199403. Okt. 1994

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WATES CITY POINT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für WATES CITY POINT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2018

    14 SeitenAA

    legacy

    186 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    3 SeitenAA

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2016

    14 SeitenAA

    legacy

    210 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Sekretär am 31. Okt. 2016

    1 SeitenTM02

    Ernennung von British Land Company Secretarial Limited als Sekretär am 31. Okt. 2016

    2 SeitenAP04

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Charles John Middleton als Direktor am 13. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Jonathan Charles Mcnuff als Direktor am 13. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 31. März 2016

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 09. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    15 SeitenAA

    legacy

    184 SeitenPARENT_ACC

    Wer sind die Geschäftsführer von WATES CITY POINT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer8992198
    187856670001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Sekretär
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    ROGERS, Edward
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    Sekretär
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    British70588860003
    WILSON, Michael Anthony
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    Sekretär
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    British68971270001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Geschäftsführer
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    CLUTTON, Rodney
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    British4388360001
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrish73961570001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Geschäftsführer
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Geschäftsführer
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    NETTLETON, John Dering
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    EnglandEnglish1866530002
    O'DONOGHUE, Mark
    10 Corrance Road
    SW2 5RH London
    Geschäftsführer
    10 Corrance Road
    SW2 5RH London
    British55336480001
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    ROGERS, Edward
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    Geschäftsführer
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    British70588860003
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001
    WATES, Paul Christopher Ronald
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    EnglandBritish2119440001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WATES CITY POINT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Wates City Of London Properties Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06. Apr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat WATES CITY POINT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 05. Juli 2004
    Geliefert am 14. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 05. Juli 2004
    Geliefert am 14. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage or first fixed charge all shares by way of a first fixed charge all related rights being any dividend or interest paid or payable in relation to any share.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 2001
    Geliefert am 31. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) and any reference thereto in the debenture shall include all or any part thereof
    Kurze Angaben
    5 cheapsidelondon EC2 t/no: NGL155905 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 31. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement between each chargor (as defined) and the agent
    Erstellt am 02. Juli 2001
    Geliefert am 16. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Freehold land k/a city point (formerly k/a britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546 for further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 16. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares between each chargor (as defined) and the agent
    Erstellt am 02. Juli 2001
    Geliefert am 16. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all shares and by way of first fixed charge all related rights including dividents please see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 16. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 18. Apr. 2001
    Geliefert am 03. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities of the company to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Facility Agent)
    Transaktionen
    • 03. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 20. März 2000
    Geliefert am 30. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each finance document
    Kurze Angaben
    By way of a first legal mortgage all shares, by way of a first fixed charge its interest in all shares and all related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Depfa Deutsche Pfandbriefbank Aktiengesellschaft (The "Agent")
    Transaktionen
    • 30. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Erworben am 17. Juli 2001
    Geliefert am 06. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital including bookdebts benefit of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2001Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 14. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to deutsche pfandbrief- und hypothekenbank aktiengesellschaft (the "agent") and the finance parties (as defined) or any of them under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1998
    Geliefert am 17. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H property k/a ling house 10-13 dominion street london t/no: LN170275 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 1997
    Geliefert am 24. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee under each of the finance documents (as therein defined) to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening S151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    F/H land k/a city tower (formerly britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Pfandbrief- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 02. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the peice of f/h and l/h land froming part of t/n's NGL686627 and LN220372 and all buildings and fixtures thereon the procceds of sale thereof and the benefit of any covenants in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC(As Agent and Trustee for Itself and Each Otherfinace Party)
    Transaktionen
    • 02. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Apr. 1996
    Geliefert am 07. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the chargor debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    Interest in an agreement dated 22ND march 1996 relating to the purchase of all that piece or parcel of land forming part of t/nos:-NGL686627 and LN220372. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0