WATES CITY POINT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WATES CITY POINT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02973114 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WATES CITY POINT LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich WATES CITY POINT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WATES CITY POINT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NUMBER 27/35 CANNON STREET LIMITED | 27. Jan. 1995 | 27. Jan. 1995 |
| BISHOLD LIMITED | 03. Okt. 1994 | 03. Okt. 1994 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WATES CITY POINT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WATES CITY POINT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 186 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2016 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 210 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Sekretär am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von British Land Company Secretarial Limited als Sekretär am 31. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Charles John Middleton als Direktor am 13. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Jonathan Charles Mcnuff als Direktor am 13. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 31. März 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 184 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WATES CITY POINT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Sekretär | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | British | 35118050001 | ||||||||||
| ROGERS, Edward | Sekretär | 89 Essex Road Islington N1 2SJ London | British | 70588860003 | ||||||||||
| WILSON, Michael Anthony | Sekretär | 4 Alleyn Road SE21 8AL London | British | 68971270001 | ||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||||||
| BERESFORD, Valentine Tristram | Geschäftsführer | 3 Smith Terrace SW3 4DL London | England | British | 40766290003 | |||||||||
| CLUTTON, Rodney | Geschäftsführer | Grange Farm CV23 8DJ Grandborough Warwickshire | British | 4388360001 | ||||||||||
| DOYLE, Eugene Francis | Geschäftsführer | 2 Gombards AL3 5NW St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | Irish | 73961570001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Geschäftsführer | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 35118050001 | |||||||||
| MCGANN, Martin Francis | Geschäftsführer | 10 Westcombe Park Road SE3 7RB Blackheath London | British | 109383240001 | ||||||||||
| NETTLETON, John Dering | Geschäftsführer | Newington House OX10 7AG Warborough Oxfordshire | England | English | 1866530002 | |||||||||
| O'DONOGHUE, Mark | Geschäftsführer | 10 Corrance Road SW2 5RH London | British | 55336480001 | ||||||||||
| PRICE, Humphrey James Montgomery | Geschäftsführer | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | 14448630001 | |||||||||
| ROGERS, Edward | Geschäftsführer | 89 Essex Road Islington N1 2SJ London | British | 70588860003 | ||||||||||
| SMITH, Andrew David | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 108214880002 | |||||||||
| STIRLING, Mark Andrew | Geschäftsführer | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | 106882210001 | |||||||||
| VAUGHAN, Patrick Lionel | Geschäftsführer | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | 73972350001 | |||||||||
| WATES, Paul Christopher Ronald | Geschäftsführer | Bellasis House Headley Heath Approach Mickleham RH5 6DH Dorking Surrey | England | British | 2119440001 | |||||||||
| NOROSE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006410001 | |||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WATES CITY POINT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wates City Of London Properties Limited | 06. Apr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat WATES CITY POINT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 05. Juli 2004 Geliefert am 14. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 05. Juli 2004 Geliefert am 14. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage or first fixed charge all shares by way of a first fixed charge all related rights being any dividend or interest paid or payable in relation to any share. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 2001 Geliefert am 31. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) and any reference thereto in the debenture shall include all or any part thereof | |
Kurze Angaben 5 cheapsidelondon EC2 t/no: NGL155905 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between each chargor (as defined) and the agent | Erstellt am 02. Juli 2001 Geliefert am 16. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Freehold land k/a city point (formerly k/a britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546 for further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares between each chargor (as defined) and the agent | Erstellt am 02. Juli 2001 Geliefert am 16. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all shares and by way of first fixed charge all related rights including dividents please see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 18. Apr. 2001 Geliefert am 03. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities of the company to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 20. März 2000 Geliefert am 30. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each finance document | |
Kurze Angaben By way of a first legal mortgage all shares, by way of a first fixed charge its interest in all shares and all related rights.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 1999 Erworben am 17. Juli 2001 Geliefert am 06. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital including bookdebts benefit of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to deutsche pfandbrief- und hypothekenbank aktiengesellschaft (the "agent") and the finance parties (as defined) or any of them under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 30. Jan. 1998 Geliefert am 17. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben F/H property k/a ling house 10-13 dominion street london t/no: LN170275 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Dez. 1997 Geliefert am 24. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee under each of the finance documents (as therein defined) to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening S151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben F/H land k/a city tower (formerly britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 31. Dez. 1996 Geliefert am 02. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the peice of f/h and l/h land froming part of t/n's NGL686627 and LN220372 and all buildings and fixtures thereon the procceds of sale thereof and the benefit of any covenants in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Apr. 1996 Geliefert am 07. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the chargor debenture contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben Interest in an agreement dated 22ND march 1996 relating to the purchase of all that piece or parcel of land forming part of t/nos:-NGL686627 and LN220372. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0